FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED

FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02246025
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FINANCIAL OPTIONS GROUP LIMITED 07 lug 199407 lug 1994
    FINANCIAL OPTIONS LIMITED20 mag 199420 mag 1994
    FINANCIAL OPTIONS GROUP LIMITED 25 apr 199425 apr 1994
    FINANCIAL OPTIONS LIMITED25 gen 198925 gen 1989
    PRINTON LIMITED20 apr 198820 apr 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 02 mag 2017

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA a No. 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 03 gen 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 dic 2016

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 nov 2016

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 18/11/2016
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 feb 2016

    Stato del capitale al 28 feb 2016

    • Capitale: GBP 114,761
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2015

    Stato del capitale al 03 nov 2015

    • Capitale: GBP 114,761
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Secretariat Friends Life 2nd Floor, One New Change London England EC4M 9EF England a Wellington Row York YO90 1WR

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di James Allen Newman come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Cowan come amministratore in data 23 giu 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2014

    Stato del capitale al 21 ott 2014

    • Capitale: GBP 114,761
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Allen Newman il 13 mag 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr James Allen Newman come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di George Higginson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Hooper come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7350629
    168876330001
    COWAN, John
    Montagu Square
    Westminster
    W1H 2LW London
    47
    United Kingdom
    Amministratore
    Montagu Square
    Westminster
    W1H 2LW London
    47
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director109138540001
    BOLTON, David Edward
    3 Belgrave Place
    Birkdale
    PR8 2EF Southport
    Merseyside
    Segretario
    3 Belgrave Place
    Birkdale
    PR8 2EF Southport
    Merseyside
    British6480990001
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    Segretario
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    BritishSolicitor33165610001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Segretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Segretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    MONGER, Diana
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Segretario
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    148087430001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Segretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    BLAKE, Brian David
    Blythe Hall
    Blythe Lane Lathom
    L40 5TY Ormskirk
    Lancs
    Amministratore
    Blythe Hall
    Blythe Lane Lathom
    L40 5TY Ormskirk
    Lancs
    BritishCompany Director6046160001
    BLAKE, Mark Steven Brodie
    Clifton House Southport Road
    PR7 1NT Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Clifton House Southport Road
    PR7 1NT Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director2523010001
    BLAKE, Michael David
    Lansdowne House
    18a Lyons Lane
    WA4 5JG Appleton Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Lansdowne House
    18a Lyons Lane
    WA4 5JG Appleton Warrington
    Cheshire
    BritishCompany Director76502560004
    BLAKE, Michael David
    Keepers Cottage
    Crook
    WN6 8LR Wigan
    Lancs
    Amministratore
    Keepers Cottage
    Crook
    WN6 8LR Wigan
    Lancs
    BritishCompany Director76502560002
    BOURKE, Evelyn Brigid
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomIrish,BritishActuary247998930001
    BUDGE, Kevin John
    The Old Nursery The Dash
    Kings Lane Longcot
    SN7 7SS Faringdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Nursery The Dash
    Kings Lane Longcot
    SN7 7SS Faringdon
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant97406200001
    COUZENS, Michael Alastair
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    Amministratore
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director75553130006
    ELLIS, Robert Gordon
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Severals
    Oakwood
    PO18 9AL Chichester
    West Sussex
    EnglandBritishSolicitor33165610001
    FEAR, Raymond Bernard
    3 Clare Close
    KT14 6RD West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    3 Clare Close
    KT14 6RD West Byfleet
    Surrey
    BritishCompliance Director41332810001
    FRANCIS, Richard
    14 Priors Meadow
    CV47 1GE Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    14 Priors Meadow
    CV47 1GE Southam
    Warwickshire
    BritishCompany Director80797800001
    HIGGINSON, George
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Northern IrelandBritishChief Operating Officer74690950003
    HOOPER, Paul
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    England
    Amministratore
    RH4 1QA Dorking
    Pixham End
    Surrey
    England
    United KingdomBritishCompany Director152500600001
    LEITH, Ronald Robert
    Swillbrook Farm Catforth Road
    Catforth
    PR4 0HE Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Swillbrook Farm Catforth Road
    Catforth
    PR4 0HE Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director27881180001
    LUNT, Christopher Mark
    68 Hurst Rise Road
    OX2 9HH Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    68 Hurst Rise Road
    OX2 9HH Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector66713250001
    MARTIN, Ivan
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    Amministratore
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Pixham End
    England
    England
    EnglandBritishExecutive Chairman123233030001
    MARTIN, Ivan
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    Amministratore
    90 Ranelagh Road
    Ealing
    W5 5RP London
    EnglandBritishCommercial Director123233030001
    MCDONAGH, Kevin Francis
    Chest Nuts Church Street
    Rudgwick
    RH12 3HJ Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Chest Nuts Church Street
    Rudgwick
    RH12 3HJ Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector36096250003
    MONGER, Diana
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary4768870003
    NEWMAN, James Allen
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    Amministratore
    Pixham End
    Dorking
    RH4 1QA Surrey
    United KingdomBritishCompany Director184671850003
    WADELIN, Mark Thomas
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    26 Kings Coughton Lane
    Kings Coughton
    B49 5QE Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director70575020005
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    Amministratore
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    82547250002
    SESAME SERVICES LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    Amministratore
    Burleigh House
    Chapel Oak Salford Priors
    WR11 8SP Evesham
    94161320001

    FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Creato il 17 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 12 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) and all monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 1ST floor capital house waterfront 2000 salford quays manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) and all monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 48/48A st james stret burnley t/n LA426175. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) and all monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 212 stamford street ashton-under-lyne t/n GM516342. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) and all monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 1 the rock bury t/n GM525805. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) and all monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 66 king william street blackburn t/n LA652183. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) and all monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 2ND floor capital house waterfront 2000 salford quays manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 gen 1999
    Consegnato il 19 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by financial options group limited to the beneficiaries pursuant to the second loan notes (both as defined in a security agency agreement dated 4 september 1998) together with interest and other charges and expenses howsoever incurred by the security trustee in connection with the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Development Limited(As Security Trustee for the Beneficiaries (as Defined))
    Transazioni
    • 19 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 22 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property at 1ST floor,capital house,waterfront 2000,salford quays,manchester and proceeds of sale thereof and all monies to be received under any policy of insurance thereon; the goodwill of business and full benefit of all licences; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security agent and trustee for and on behalf of the beneficiaries (as defined)) pursuant to a guarantee of even date
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 1 the rock bury t/n GM525805. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited(As Security Agent and Trustee for an on Behalfof the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 66 king william street blackburn t/n LA652183. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited(As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 48/48A st james street burnley t/n LA426175. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited(As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 2ND floor capital house waterfront road salford quays manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited(As Security Agent and Trustee for an on Behalfof the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 1ST floor capital house waterfront road salford quays manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited(As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 212 stamford street ashton under lyne t/n GM516342. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Industrial Developments Limited(As Security Agent and Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property at 66 king william st,blackburn; t/no la 652183. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property at 212 stamford st,ashton under lyne; t/no GM516342. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property - 48/48A st james street,burnley; t/no la 426175. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property at 1 the rock,bury; t/no gm 525805. and the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property at 2ND floor,capital house,waterfront 2000,salford quays,manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 set 1998
    Consegnato il 07 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FINANCIAL OPTIONS SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 dic 2016Inizio della liquidazione
    06 ott 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0