LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED

LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLIONSGATE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02247762
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PORTFOLIO ESTATES LIMITED08 set 199708 set 1997
    DUKEMINSTER LIMITED14 lug 198814 lug 1988
    VALUEMAJOR PUBLIC LIMITED COMPANY25 apr 198825 apr 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175(5)(a) 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    C/O Reit Asset Management
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    C/O Reit Asset Management
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICES LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    Amministratore
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor 5
    135401070001
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Segretario
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    British50173270002
    JACOBS, Adrian Mark
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    Segretario
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    British59392140001
    SAMUELS, Adam Bernard Andrew
    49 Plymouth Wharf
    Isle Of Dogs
    E14 3EL London
    Segretario
    49 Plymouth Wharf
    Isle Of Dogs
    E14 3EL London
    British9202270001
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Segretario
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    AARONSON, Glenn Hunter
    Little Stone House Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Little Stone House Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haslemere
    Surrey
    Us Citizen61193890001
    BENJAMIN, William Stephen
    44 Campden Hill Square
    Holland Park
    W8 7JR London
    Amministratore
    44 Campden Hill Square
    Holland Park
    W8 7JR London
    United KingdomBritish71600980002
    BINNINGTON, Timothy John
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    Amministratore
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritish4831260001
    BLENKO, Don Balman
    27 Burlington Gardens
    W4 4LT London
    Amministratore
    27 Burlington Gardens
    W4 4LT London
    UsaUk Us45456900001
    FALLS, Robert Richard William
    28b Chalcot Road
    Primrose Hill
    NW1 8LN London
    Amministratore
    28b Chalcot Road
    Primrose Hill
    NW1 8LN London
    British16501250004
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish50173270002
    KHALASTCHI, Ephraim Menashi Frank
    Flat 65 Waterside Point
    2 Anhalt Road
    SW11 4PD London
    Amministratore
    Flat 65 Waterside Point
    2 Anhalt Road
    SW11 4PD London
    EnglandBritish56359120001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Amministratore
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    NASH, Jeffrey Frederick
    The Coach House St Matthews Road
    Ealing
    W5 3JT London
    Amministratore
    The Coach House St Matthews Road
    Ealing
    W5 3JT London
    United KingdomBritish53992520001
    NEWMAN, Graeme Phillip
    Magpies Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Magpies Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    British4831270001
    ORF, Roger Gerard
    Pelham Crescent
    SW7 2NP London
    1
    Amministratore
    Pelham Crescent
    SW7 2NP London
    1
    United KingdomBritish38079110001
    PASHLEY, Michael
    31 Saint Michaels Road
    MK40 2LZ Bedford
    Amministratore
    31 Saint Michaels Road
    MK40 2LZ Bedford
    British77493420001
    PATRICK, Christopher John
    12 Fitzroy Crescent
    Chiswick Place
    W4 3EL London
    Amministratore
    12 Fitzroy Crescent
    Chiswick Place
    W4 3EL London
    Usa48804210001
    PERHIA, Naomi
    10 Mortimer Road
    Ealing
    W5 London
    Amministratore
    10 Mortimer Road
    Ealing
    W5 London
    British19820830001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Amministratore
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SHOHET, Edward
    77 Bryanston Court (No 2)
    137 George Street
    W1H 7AD London
    Amministratore
    77 Bryanston Court (No 2)
    137 George Street
    W1H 7AD London
    Italian35535690002
    SHOHET, Meir Miro
    Goya 47
    Madrid
    28001
    Spain
    Amministratore
    Goya 47
    Madrid
    28001
    Spain
    SpainBritish96891340001
    SHOHET, Saleh Haron
    Flat J Upper Fielde
    71 Park Street
    W1Y 3HB London
    Amministratore
    Flat J Upper Fielde
    71 Park Street
    W1Y 3HB London
    EnglandBritish17408410003
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    LIONSGATE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of legal charge
    Creato il 22 mar 2000
    Consegnato il 25 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from any group member (as defined ) to norwich union mortgage finance limited (the "trustee") or any lender (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Surrey house and department store,high street,throwley road and throwley way,sutton t/no.sgl 192010.fixed charge all moneys from time to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 of the deed.floating charge such of its undertaking which is not otherwise charged pursuant to clauses 3.1(a),3.1(b) or 3.2 of the deed.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 15 nov 1999
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H property k/a land lying on the north-east side of dunstable road luton t/n BD90802.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Supplemental deed
    Creato il 20 giu 1999
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H property k/a wedge house 799 london road croydon t/n SGL15383. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Supplemental deed
    Creato il 22 dic 1998
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H property k/a 95 kilburn high road l/b of camden t/n 346021. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Legal charge
    Creato il 11 lug 1997
    Consegnato il 23 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property situate at and k/a land on the east side of london road peterborough t/n CB168963 all rents and other income.
    Persone aventi diritto
    • American Express Bank Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 27 giu 1997
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 10 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (I) f/hold property known as 100-102 uxbridge rd,hammersmith; t/no NGL421539 and described as wellington public house and 96-102 uxbridge rd,london W.12; (ii) f/hold property known as 39/41 high street and 56/60 calthorpe st,banbury; ON186122; (iii) f/hold land lying to the west of calthorpe st,banbury; ON190050; all buildings,fixtures plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 10 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Supplemental deed
    Creato il 27 giu 1997
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H property k/a castle house 37-45 (odd) paul street l/b of islington t/n NGL488502.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Floating charge
    Creato il 26 mag 1997
    Consegnato il 06 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 03 feb 1997
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a 89,91,93,95 and 97 london street and 56 58 and 60 east street reading t/n BK762118. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Supplemental deed
    Creato il 03 feb 1997
    Consegnato il 12 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies and indebtedness due from the company,turnshire limited and chaselands limited and any other group member (as defined) to the chargee as trustee for itself and the other lenders and to any other lenders supplemental to the legal charge dated 23RD december 1996
    Brevi particolari
    89 91 93 95 & 97 london street and 56,58 & 60 east street reading title number BK76218 with all buildings erections and fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 12 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed of legal charge
    Creato il 31 dic 1996
    Consegnato il 14 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    £10,000,000 due or to become due from the company to the chargee secured by the loan agreement dated 31ST december 1996
    Brevi particolari
    All sums from time to time standing to the credit of the borrowers account open or to be opened in the lenders books entitle norwich union mortgage finance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 14 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of legal charge
    Creato il 23 dic 1996
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H property k/a bakery house 27/29 buckingham street and rycote house 23/25 buckingham street aylesbury in the county of buckinghamshire t/n BM204069 and bm 192803. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Deed of legal charge
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 07 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or incurred by the company,chaselands limited,soundmen limited and any other group member (as defined) to the chargee as agent for itself and others and to any lenders (as defined) on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 2 to 26 rushbottom lane great tarpots south byfleet essex t/n EX498562 with all buildingg fixtures and fittings and by way of floating charge all property assets and rights of the company.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 07 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security
    Creato il 22 dic 1995
    Consegnato il 23 dic 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Seafield road inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 23 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of legal charge
    Creato il 20 dic 1995
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    F/H land lying to the east of dragon lane gilesgate moor durham in the county of durham t/n DU86462. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Deed of agreement
    Creato il 20 dic 1995
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    £8,010,000
    Brevi particolari
    Land on the north side of winterstone road weston super mare t/n AV247071.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Deed of legal charge and mortgage
    Creato il 20 dic 1995
    Acquisito il 22 mar 2000
    Consegnato il 04 apr 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north ide of stanley road whitefield bury greater manchester k/a safeway supermarket bury t/n LA313417 f/h land and buildings lying to the south of elms street whitefield bury greater manchester t/n GM26271. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2000Registrazione di un'acquisizione (400)
    Deed of legal charge and mortgage
    Creato il 20 dic 1995
    Consegnato il 09 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 09 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of legal charge and mortgage
    Creato il 20 dic 1995
    Consegnato il 05 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land lying to the north east of sealand road chester cheshire t/n CH233052 and f/h land lying to the north of sealand road chester cheshire t/n CH96799 (and other properties as defined), the benefit of an environmental consultants deed of warranty dated 20/12/94, floating charge the. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 05 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH may 1996
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 24 mag 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Seafield road inverness.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 24 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15TH may 1996
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 17 mag 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    107 kelvinhaugh street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 17 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15TH may 1996
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 17 mag 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    107 kelvinhaugh street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 17 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 6TH january 1996
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 26 gen 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1.03 acres at seafield road inverness.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 26 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 23 dic 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Strathmartine road,dundee.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for reguistration in scotland on the 22ND december 1995
    Creato il 19 dic 1995
    Consegnato il 23 dic 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Slateford road edinburgh.
    Persone aventi diritto
    • The Norwich Union Life Insurance Society
    Transazioni
    • 23 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0