COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02248411 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
- Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street SW1H 0AD London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COUNTY & SURBURBAN CARE LIMITED | 26 apr 1988 | 26 apr 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 20 lug 2015 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building, 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 05 ago 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Jonathan David Farkas come amministratore in data 27 gen 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mathieu Streiff come amministratore in data 27 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 28 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mathieu Streiff il 31 mar 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 31 mar 2014 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* in data 08 apr 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2014 al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Sanne Group Secretaries (Uk) Limited come segretario | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Segretario | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England |
| 175738460001 | ||||||||||
| FARKAS, Jonathan David | Amministratore | Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor 21 | Luxembourg | American | 193539990001 | |||||||||
| BUTLER, John | Segretario | Magnolia Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | British | 4526760004 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Segretario | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||||||
| BRONOCK, Brian Paul | Amministratore | Well Springs Orchard Well Springs Brightwell Cum Sotwell OX10 0RN Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 46299650003 | |||||||||
| BRONOCK, Catherine Mary | Amministratore | Wells Springs Orchard Well Springs, Brightwell Cumsotwell OX10 0RN Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 17925460002 | |||||||||
| BUTLER, Brenda | Amministratore | Magnolia Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | England | British | 10952670003 | |||||||||
| BUTLER, John | Amministratore | Magnolia Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | England | British | 4526760004 | |||||||||
| CORMACK, Derek George | Amministratore | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | 67400530015 | |||||||||
| GRIFFIN, Craig | Amministratore | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | 154122490001 | |||||||||
| HILL, Peter Martin | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 130983750002 | |||||||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 65609290003 | |||||||||
| LANGAN, Michael John | Amministratore | 68 Hitherbroom Road UB3 3AE Hayes Middlesex | United Kingdom | British | 50177330001 | |||||||||
| O'BRIEN, Bernard Vincent | Amministratore | 1 Braemar House Orchehill House Orchehill Avenue SL9 8QS Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 69342790002 | ||||||||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||||||
| STREIFF, Mathieu Bernard | Amministratore | Pollen House 10 Cork Street W1S 3NP London 2nd Floor | United States | American | 200529310001 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Amministratore | Bradbury House 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Essex | England | British | 133383410003 | |||||||||
| WHITE, Ian James | Amministratore | Wetherden Road Haughley IP14 3RE Stowmarket Wetherden Cottage Suffolk United Kingdom | England | British | 133383410003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ga Hc Reit Ch Uk Senior Housing Portfolio Limited | 06 apr 2016 | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building, 2nd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
COUNTY & SUBURBAN CARE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 28 lug 2010 Consegnato il 06 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession and charge | Creato il 17 gen 2008 Consegnato il 29 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 nov 2007 Consegnato il 27 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 ott 2005 Consegnato il 03 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 ott 2001 Consegnato il 30 ott 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 14 feb 1996 Consegnato il 19 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or brocklan investments limited and/or burnham lodge care limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 18 feb 1991 Consegnato il 27 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or brocklan investments limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0