CORBY TC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCORBY TC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02248576
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CORBY TC LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova CORBY TC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Sloane Square
    SW1W 8ER London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CORBY TC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HELICAL (CORBY) LIMITED15 nov 201115 nov 2011
    TOPS SHOP PRECINCTS LIMITED20 mag 198820 mag 1988
    MONORARE LIMITED27 apr 198827 apr 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di CORBY TC LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2015
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CORBY TC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 nov 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Pricewaterhouse Coopers Llp 7 More London Riverside London SE1 2RT United Kingdom a 15 Sloane Square London SW1W 8ER in data 02 giu 2015

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Hanover Square London W1S 1HQ a Pricewaterhouse Coopers Llp 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 13 apr 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Hugo Marcus Vernon Black come amministratore in data 16 mar 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Justin Bhalla come segretario in data 16 mar 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Duncan Charles Eades Walker come amministratore in data 16 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Eric Slade come amministratore in data 16 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helical Registrars Limited come segretario in data 16 mar 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Charles Inwood come amministratore in data 16 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Philip Palmer Anderson come amministratore in data 16 mar 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy John Murphy come amministratore in data 16 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert David Criag Sim come amministratore in data 16 mar 2015

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 ott 2014

    Stato del capitale al 27 ott 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Helical Registrars Limited il 26 ago 2014

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da 11-15 Farm Street London W1J 5RS a 5 Hanover Square London W1S 1HQ in data 28 ago 2014

    1 pagineAD01

    Parte della proprietà o attività non fa più parte dell'onere 24

    2 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività non fa più parte dell'onere 24

    2 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività non fa più parte dell'onere 24

    2 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di CORBY TC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BHALLA, Justin
    15 Sloane Square
    SW1W 8ER London
    Europa Capital Partners Llp
    United Kingdom
    Segretario
    15 Sloane Square
    SW1W 8ER London
    Europa Capital Partners Llp
    United Kingdom
    196676720001
    BLACK, Hugo Marcus Vernon
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    Amministratore
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    United KingdomBritish179500420001
    SIM, Robert David Craig
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    Amministratore
    Sloane Square
    SW1W 8ER London
    15
    England
    EnglandBritish153901920001
    COHEN, Adam Hayden
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    Segretario
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    British205044390001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Segretario
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    HELICAL REGISTRARS LIMITED
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Segretario
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04701446
    89869830001
    LS COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Strand
    WC2N 5AF London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4365193
    159674790001
    AKERS, Richard John
    Shepherds Down
    Hill Road
    GU27 2NH Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Shepherds Down
    Hill Road
    GU27 2NH Haslemere
    Surrey
    United KingdomEnglish73246590001
    ANDERSON, Thomas Philip Palmer
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritish160720640002
    COHEN, Adam Hayden
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Baram
    64 Galley Lane
    EN5 4AL Arkley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish205044390001
    DESSON, Ernest Vincent
    Meadows
    Rickmans Lane
    RH14 0NT Plaistow
    West Sussex
    Amministratore
    Meadows
    Rickmans Lane
    RH14 0NT Plaistow
    West Sussex
    British14948630001
    GARROD, Douglas Victor
    Westmorland House
    Station Road
    RG17 9UP Kintbury
    Berkshire
    Amministratore
    Westmorland House
    Station Road
    RG17 9UP Kintbury
    Berkshire
    EnglandBritish104783210001
    GILL, Christopher Marshall
    Church Street
    KT17 4QA Epsom
    63
    Surrey
    Amministratore
    Church Street
    KT17 4QA Epsom
    63
    Surrey
    United KingdomBritish133825020001
    GOODMAN, Everard Nicholas
    5 Bryanston Court
    W1H 7HA London
    Amministratore
    5 Bryanston Court
    W1H 7HA London
    United KingdomBritish3080770001
    INWOOD, John Charles
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    United KingdomBritish56398550002
    LAYCOCK, Anthony Ernest
    One Shoreham Lane
    TN13 3DT Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    One Shoreham Lane
    TN13 3DT Sevenoaks
    Kent
    British35572520001
    LEVY, Jonathan Adrian
    2 St Marks Road
    TW11 9DD Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    2 St Marks Road
    TW11 9DD Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish124364140001
    MCNAIR SCOTT, Nigel Guthrie
    Farm Street
    W1J 5RS London
    11-15
    United Kingdom
    Amministratore
    Farm Street
    W1J 5RS London
    11-15
    United Kingdom
    EnglandBritish6065190002
    MURPHY, Timothy John
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritish40547240005
    PATTESON-KNIGHT, Richard Julian
    Gadbrook House
    Gadbrook Road
    RH3 7AH Betchworth
    Surrey
    Amministratore
    Gadbrook House
    Gadbrook Road
    RH3 7AH Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish55013110001
    SHARPE, Darren John
    192 Noak Hill Road
    CM12 9UX Billericay
    Essex
    Amministratore
    192 Noak Hill Road
    CM12 9UX Billericay
    Essex
    United KingdomBritish30525300003
    SLADE, Michael Eric
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritish38913980001
    SMITH, Roger Peter
    Bramble Lodge
    Saunders Copse
    GU22 0NS Mayford
    Surrey
    Amministratore
    Bramble Lodge
    Saunders Copse
    GU22 0NS Mayford
    Surrey
    British40397900001
    WALKER, Duncan Charles Eades
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    Amministratore
    Hanover Square
    W1S 1HQ London
    5
    England
    EnglandBritish129346360008
    WOOD, Martin Reay, Mr.
    Kingsdale Road
    HP4 3BS Berkhamsted
    Weavers
    Herts
    Amministratore
    Kingsdale Road
    HP4 3BS Berkhamsted
    Weavers
    Herts
    EnglandBritish89486930002
    LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Amministratore
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    74974580001
    LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    Amministratore
    5 Strand
    WC2N 5AF London
    100069790001

    CORBY TC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 feb 2012
    Consegnato il 10 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 ott 2013Parte della proprietà o dell'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 23 ott 2013Parte della proprietà o dell'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 23 ott 2013Parte della proprietà o dell'impresa non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 23 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 ott 2011
    Consegnato il 25 ott 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 ott 2013Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 08 mag 2009
    Consegnato il 13 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    City exchange 11 albion street leeds t/no WYK880421 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 23 set 2008
    Consegnato il 25 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the west of elizabeth street corby t/no 163390,two parcels of land and buildings on the west side of elizabeth street corby t/no NN128983,land and buidlings in spencer court corby t/no NN150323 (for further details of property charged please refer to form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As "Obligor Security Trustee")
    Transazioni
    • 25 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Obligor accession deed
    Creato il 23 set 2008
    Consegnato il 25 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge any real property,all plant,machinery and other chattels,the obligor accounts,all ahres held by it and all dividends see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (As "Obligor Security Trustee")
    Transazioni
    • 25 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Socttish assignation in security
    Creato il 24 mar 2000
    Consegnato il 13 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whatsoever of each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties and to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit in the ent collection account together with all balances standing to the credit thereof for full details please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank
    Transazioni
    • 13 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 24 mar 2000
    Consegnato il 03 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets and moneys over the property (as defined) and benefits in respect of insurances; all book/other debts and licences,consents,rights under any agreement; all rental income.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank,London Branch Asagent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 03 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 29 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 01 mar 1999
    Consegnato il 03 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    In favour of the chargee the principal of and interest on £75,000,000 in nominal amount of 10 1/4 per cent first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other monies intended to be secured by a trust deed dated 19TH may 1986 and three supplemental trust deeds dated 30TH march 1987, 22ND february 1989 and 7TH april 1992 respectively
    Brevi particolari
    F/H 26 to 34 (even numbers) albion street leeds t/n-WYK156991. L/h being a storeroom forming part of trinity street arcade albion street leeds t/n-WYK285921.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 03 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1998
    Consegnato il 13 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at victoria gardens shopping centre harrogate north yorkshire t/nos: NYK20654 and NYK202690. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 16 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal and interest on £75,000,000 in nominal amount of 10 1/4% first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other monies secured by the trust deeds (as therein defined) due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and buildings k/a 38-40 queens square corby northamptonshire t/n NN178555 and the f/h land an buildings k/a 41-44 queens square, 47 and 48 market walk, 9,10 and 11 the links and chisholm house (including the entrance thereof at groud level) corby northamptonshire t/n's NN178568, NN178555 and NN128983.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited(As Trustee)
    Transazioni
    • 16 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge (third party)
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or tops estates PLC to the chargee under the loan agreement (as defined), the legal charge or the security documents
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a spencer court mall corby t/no.NN150323 and all that f/h land k/a new post office square corby t/nos.NN150320 and NN157416 and all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 gen 1995
    Consegnato il 10 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the bamber bridge shopping centre, preston t/nos. LA701840 and LA706485 and f/h property k/a 51 warrington street, ashton-under-lyne t/no. GM644617.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 1994
    Consegnato il 25 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    38, 39 & 40 queens square, 29, 30 & 31 market walk, queens square and 32 queens square, 41-46 (incl.) queens square, 47 & 48 market walk, 9, 10 & 11 the links and chisholm house, queens square, 1-5 (incl.) and 6/7 the links, corby, northamptonshire, being part of the land comprised in t/no. NN128983.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 1994
    Consegnato il 25 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deene house, market square, corby, northamptonshire t/no. NN145263.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 lug 1994
    Consegnato il 20 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the bond street centre k/a land and buildings on the south side of bond street and west side of albion street, leeds t/no. YWE70082 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 giu 1994
    Consegnato il 30 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 1994
    Consegnato il 18 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ashton-under-lyne shopping centre, tameside, greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over rental income
    Creato il 06 lug 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the hongkong and shanghai banking corporation limited as agent for itself and the beneficiaries under the terms of any security document (as defined) and this charge.
    Brevi particolari
    First fixed charge over all monies now or hereafter standing in the credit of : the rental income account being three accounts of the company with midland bank PLC london property & construction area office 3RD floor 117 great portland street london wia 4UY sort code 40-05-22 bearing account numbers: current account 31148613:money master account:31148605 money market account:un-numbered.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries.
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1993
    Consegnato il 01 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the hongkong and shanghai banking corporation limited, as agent for itself and the beneficiaries under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 26 and 27 new post office square, corby, n orthamptonshire - title no. NN150320, (see ch microfiche for full details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 01 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 26 feb 1993
    Consegnato il 01 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the chargee under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over all monies standing to the credit of the rental income account being an account with the agent bearing account no. 074-000449-151 and the property sales accouont being an account of the company with the agent bearing account no. 74-000449-152 (see ch microfiche for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 01 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over construction contract
    Creato il 26 feb 1993
    Consegnato il 01 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or marklands limited to the chargee as agent for itself and the beneficiaries under the terms of an agreement dated 24/2/93 and under the charge
    Brevi particolari
    All the company's present and future rights title and interest in and to the construction contract dated 14/10/91 for the construction of a shell and core retail units blocks a and b at st andrew market square, corby, northamptonshire to be carried out by the contractor together with any bond issued pursuant thereto (see ch microfiche for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limitedas Agent for Itself and the Beneficiaries
    Transazioni
    • 01 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third supplemental trust deed
    Creato il 09 apr 1992
    Consegnato il 14 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000,000 10 1/4% first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and all other moneys due or to become due to the chargee (the trustees of the said stock) under the deeds constituting and securing the said stock
    Brevi particolari
    F/H land on the north and west side of longcauseway dewsbury kirklees west yorkshire t/n wyk 157919 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 1989
    Consegnato il 01 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Corby town centre, northamptonshire together with the fixed plant machinery & other fixtuers. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 01 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    Second supplemental trust deed
    Creato il 22 feb 1989
    Consegnato il 28 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    50,000,000 10 1/4 % first mortgage debenture stock 2011/16 of tops estates PLC and interest thereon and all other moneys intended to be secured by the deeds as defined.
    Brevi particolari
    F/H land on the north and west side of longcauneway dewsbury. Kirklees, west yorkshire title no wyk 157919 freehold land lying to the west of longcauneway dewsbury aforesaid. Title no wyk 243684 with bldgs, fixtures etc.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 28 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CORBY TC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 nov 2015Inizio della liquidazione
    17 apr 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0