POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED

POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02251321
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POINTER PLASTICS LIMITED04 mag 198804 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 gen 2015

    19 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 24 gen 2014

    26 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 11 ago 2013

    25 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    39 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Bellway Court Silkwood Park Wakefield West Yorkshirewf5 9Tl* in data 18 feb 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di John Stirling come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 apr 2012

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 lug 2012

    Stato del capitale al 13 lug 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    4 pagineAUD

    Nomina di Mr James Joseph Michael Faulds come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di John Henry Stirling come segretario

    2 pagineAP03

    legacy

    7 pagineMG01

    Cessazione della carica di Richard Barfield come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Barfield come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew David Steel come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 apr 2011

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Trevor O'reilly come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FAULDS, James Joseph Michael
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Yorkshire
    ScotlandBritish571840010
    STEEL, Andrew David
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Yorkshire
    Amministratore
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    Yorkshire
    EnglandBritish142266440002
    BARFIELD, Richard Timothy
    Bellway Court
    Silkwood Park
    Wakefield
    West Yorkshirewf5 9tl
    Segretario
    Bellway Court
    Silkwood Park
    Wakefield
    West Yorkshirewf5 9tl
    149687800001
    BELLM, Julie Ann
    34 Banks Road
    Aylestone
    LE2 8HA Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    34 Banks Road
    Aylestone
    LE2 8HA Leicester
    Leicestershire
    British13476720001
    CROFT, Robert
    109 South Knighton Road
    LE2 3LT Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    109 South Knighton Road
    LE2 3LT Leicester
    Leicestershire
    British12331930002
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Segretario
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    British129305300001
    SHAW, Mark
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Sutton-In-Ashfield
    Skegby Lodge
    Nottinghamshire
    Segretario
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Sutton-In-Ashfield
    Skegby Lodge
    Nottinghamshire
    British146295700001
    SLACK, Philip Robert
    5 Saint Davids Close
    Leicester Forest East
    LE3 3LU Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    5 Saint Davids Close
    Leicester Forest East
    LE3 3LU Leicester
    Leicestershire
    British111559030001
    STIRLING, John Henry
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    168886580001
    BARFIELD, Richard Timothy
    Bellway Court
    Silkwood Park
    Wakefield
    West Yorkshirewf5 9tl
    Amministratore
    Bellway Court
    Silkwood Park
    Wakefield
    West Yorkshirewf5 9tl
    United KingdomBritish149689590001
    BURCHNALL, David Eric
    6 Nursery Gardens
    LE9 7JE Earl Shilton
    Leicester
    Amministratore
    6 Nursery Gardens
    LE9 7JE Earl Shilton
    Leicester
    United KingdomBritish93648110002
    COLTMAN, Ian Terence
    Apple Tree Barn
    37a High Street
    NN6 7HT Welford
    Northants
    Amministratore
    Apple Tree Barn
    37a High Street
    NN6 7HT Welford
    Northants
    British72214000003
    CROFT, Robert
    109 South Knighton Road
    LE2 3LT Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    109 South Knighton Road
    LE2 3LT Leicester
    Leicestershire
    British12331930002
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    Amministratore
    10 Church Lane
    Bardsey
    LS17 9DH Leeds
    South Acre
    W Yorkshire
    EnglandBritish129305300001
    FLETCHER, Mark
    Mulberry Barn Middle Poultney
    Farm Lutterworth Road
    LE17 6JF North Kilworth
    Amministratore
    Mulberry Barn Middle Poultney
    Farm Lutterworth Road
    LE17 6JF North Kilworth
    British92166100002
    KNIGHTS, Gary
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Hutleys 59 Church Street
    Coggeshall
    CO6 1TY Colchester
    Essex
    United KingdomBritish45695650002
    O'REILLY, Trevor John
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Silkwood Park
    WF5 9TL Wakefield
    Bellway Court
    West Yorkshire
    United Kingdom
    IrelandIrish148130760001
    RONALD, William David Gordon
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Aston
    RG9 3DE Henley On Thames
    Highway Cottage
    Oxfordshire
    EnglandBritish138299060001
    SEARSON, Jonathan David
    Pear Tree Farm
    39 Old Parsonage Lane
    LE12 5SG Hoton Loughborough
    Leicester
    Amministratore
    Pear Tree Farm
    39 Old Parsonage Lane
    LE12 5SG Hoton Loughborough
    Leicester
    EnglandBritish72213940005
    SHAW, Mark
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Skegby Lodge
    Woodhouse Lane
    NG17 3BZ Skegby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107353690001
    SLACK, Philip Robert
    5 St Davids Close
    Leicester Forest East
    LE3 3LU Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    5 St Davids Close
    Leicester Forest East
    LE3 3LU Leicester
    Leicestershire
    British71296690001
    THOMPSON, Susan
    94 Station Road
    Ratby
    LE6 0JN Leicester
    Amministratore
    94 Station Road
    Ratby
    LE6 0JN Leicester
    British72214050001

    POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 15 mar 2012
    Consegnato il 23 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 23 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    An amendment and restatement deed
    Creato il 21 set 2011
    Consegnato il 27 set 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts and uncalled capital (for details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Grace Bay Holding Ii S.A.R.L
    Transazioni
    • 27 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A security debenture
    Creato il 19 ago 2011
    Consegnato il 06 set 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of further properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Grace Bay Holding Ii S.A.R.L
    Transazioni
    • 06 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security confirmation and supplemental deed
    Creato il 13 giu 2011
    Consegnato il 17 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security confirmation and supplemental deed
    Creato il 24 feb 2011
    Consegnato il 08 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Charged by way of fixed charge all shares all related distribution rights all investment and all related distribution rights all book debts and all benefits rights and security held in respect of or to secure the payment of the book debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties, the Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A confirmatory deed
    Creato il 18 dic 2009
    Consegnato il 04 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A confirmatory deed
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 14 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Confirmatory deed supplemental to a debenture originally dated 19 august 2005 and
    Creato il 17 mar 2009
    Consegnato il 25 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 20 mar 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security accession deed
    Creato il 10 ott 2006
    Consegnato il 18 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares. All related distribution rights and investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 01 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sandretto nove t 500 used s/no M9280003 2004 injection moulding machine.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)

    POINTER DESIGN AND MANUFACTURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 feb 2013Inizio dell'amministrazione
    24 gen 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Matthew David Smith
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DataTipo
    24 gen 2014Inizio della liquidazione
    02 lug 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Matthew David Smith
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0