STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED

STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02252848
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (714) LIMITED09 mag 198809 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    10 pagineLIQ10

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 feb 2017

    13 pagine4.68

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 55 Baker Street London W1U 8EW

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Baker Street London W1U 8EW United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 25 feb 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 feb 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da The Management Suite 5 Ironbridge Road Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1HB a 55 Baker Street London W1U 8EW in data 07 ago 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Masazumi Maeda come amministratore in data 29 mag 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Hiroaki Iizawa come amministratore in data 29 mag 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Martin Towns come amministratore in data 05 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2015

    Stato del capitale al 13 apr 2015

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 ott 2014

    • Capitale: GBP 20,000
    4 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2014

    Stato del capitale al 22 apr 2014

    • Capitale: GBP 58,013,120
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHEADLE, Jayne
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Segretario
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    British97029880002
    HARCOURT, John Benjamin
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomNew ZealanderDevelopment Director140163750001
    MAEDA, Masazumi
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomJapaneseCompany Director198376850001
    PERKINS, Christopher Mark Gordon
    55 Basinghall Street
    EC2V 5DU London
    City Place House
    England
    England
    Amministratore
    55 Basinghall Street
    EC2V 5DU London
    City Place House
    England
    England
    United KingdomBritishSurveyor98055280002
    RUDD-JONES, Julian Mark
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritishProperty Developer129365690001
    VICIANA, James Joseph
    3145 S0. Atlantic Ave.
    Daytona
    Florida 32118
    United States
    Amministratore
    3145 S0. Atlantic Ave.
    Daytona
    Florida 32118
    United States
    United StatesAmericanConsultant115944070001
    HARVEY, George Kenneth
    Brownleas
    52 Aldwick Avenue
    PO21 3AQ Bognor Regis
    West Sussex
    Segretario
    Brownleas
    52 Aldwick Avenue
    PO21 3AQ Bognor Regis
    West Sussex
    British86329780001
    RUTHERFORD, Michael Paul
    6 Leigh Road
    KT11 2LD Cobham
    Surrey
    Segretario
    6 Leigh Road
    KT11 2LD Cobham
    Surrey
    BritishAccountant59674940002
    VANDER MEERSCH, Caroline Anne
    31 Elaine Grove
    NW5 4QH London
    Segretario
    31 Elaine Grove
    NW5 4QH London
    British105842520001
    WISNIEWSKI, Damian Mark Alan
    34 Bristol Gardens
    Little Venice
    W9 2JQ London
    Segretario
    34 Bristol Gardens
    Little Venice
    W9 2JQ London
    British19296830001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Amministratore
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    BritishCompany Director2996750001
    CODLING, John Piers
    Smithy Cottage
    High Street
    HP7 0DY Little Missenden
    Bucks
    Amministratore
    Smithy Cottage
    High Street
    HP7 0DY Little Missenden
    Bucks
    BritishChartered Surveyor26235710001
    DANTZIC, Roy Matthew
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Amministratore
    65 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    BritishDirector52294450003
    HANKIN, Trevor John
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritishSurveyor72307390002
    ICHIKI, Hiroto
    9 Radnor Road
    TW1 4NJ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    9 Radnor Road
    TW1 4NJ Twickenham
    Middlesex
    JapaneseManager73837480002
    IIZAWA, Hiroaki
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    The Management Suite
    5 Ironbridge Road Stockley Park
    UB11 1HB Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomJapaneseDirector139465290001
    ISHIYAMA, Tsutomu
    1 Corringham Road
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Amministratore
    1 Corringham Road
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    JapaneseDirector35181340001
    LUCAS, Barry
    40 Grovelands Road
    Palmers Green
    N13 4RH London
    Amministratore
    40 Grovelands Road
    Palmers Green
    N13 4RH London
    BritishProject Director6709900001
    MCCULLOCH, Greg
    54 Ingatestone Road
    IG8 9AL Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    54 Ingatestone Road
    IG8 9AL Woodford Green
    Essex
    United KingdomCanadianProperty Consultant124564390001
    MCDIVEN, Ross Arnold
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    U 9 38 Bay Street
    NSW 2028 Double Bay
    New South Wales
    Australia
    AustralianCompany Director108719480001
    MEERSCH, Andrew David Vander
    31 Elaine Grove
    NW5 4QH London
    Amministratore
    31 Elaine Grove
    NW5 4QH London
    United KingdomBritishChartered Engineer91429300001
    METTER, David Antony
    W2
    Amministratore
    W2
    United KingdomBritishExecutive17535810001
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Amministratore
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritishDirector65062400001
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Amministratore
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritishDirector65062400001
    SHIBASAKI, Katsumi
    6 Marlborough Hill
    St Johns Wood
    NW8 0NN London
    Amministratore
    6 Marlborough Hill
    St Johns Wood
    NW8 0NN London
    JapanesePresident And Ceo92075590001
    SUZUKI, Fujio
    5 Randolph Close
    Stoke Dabernon
    KT11 2SW Cobham
    Surrey
    Amministratore
    5 Randolph Close
    Stoke Dabernon
    KT11 2SW Cobham
    Surrey
    JapaneseCompany Director65931220002
    THOMPSON, Nicholas Henry Croom
    Longwood
    Orchehill Avenue
    SL9 8QJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Longwood
    Orchehill Avenue
    SL9 8QJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFund Manager227950002
    TOWNS, Martin
    55 Basinghall Street
    EC2V 5DU London
    City Place House
    England
    England
    Amministratore
    55 Basinghall Street
    EC2V 5DU London
    City Place House
    England
    England
    United KingdomScottishChartered Surveyor161527160001
    TURNER, Malcolm Robin
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    Amministratore
    18 Jay Mews
    SW7 2EP London
    United KingdomBritishEstate Agent60293070001
    UCHIDA, Koji
    Nakano-Ku Tokyo
    Shirasagi
    FOREIGN 3-18-5 Japan
    Amministratore
    Nakano-Ku Tokyo
    Shirasagi
    FOREIGN 3-18-5 Japan
    JapaneseGeneral Manager31558180001
    WYTHE, John Michael
    Woodpeckers
    Ashwood Road
    GU22 7JN Woking
    Surrey
    Amministratore
    Woodpeckers
    Ashwood Road
    GU22 7JN Woking
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor27660380001
    YAMAMOTO, Taizo
    High Trees
    41 Hillside
    SM7 1HG Banstead
    Surrey
    Amministratore
    High Trees
    41 Hillside
    SM7 1HG Banstead
    Surrey
    JapaneseCompany Director49863440002
    YASUHARA, Atsushi
    140 Corringway
    Ealing
    W5 3HA London
    Amministratore
    140 Corringway
    Ealing
    W5 3HA London
    United KingdomJapaneseEngineer106738210001

    STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 01 lug 1999
    Consegnato il 14 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined) any account whatsoever
    Brevi particolari
    The entire issued share capital of the borrower and by way of a first fixed charge all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 10 nov 1997
    Consegnato il 18 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    4 the square stockley park and all plant and machinery. All monies standing to the credit of the security accounts and the debts represented by them. The benefit of insurances licences consents authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD
    Transazioni
    • 18 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment (the "deed")
    Creato il 26 set 1997
    Consegnato il 06 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined) except for any obligation which if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    All rights under the assigned property meaning all monies payable under the agreement for development and letting dated 26/9/97. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Sakura Bank, Limited
    Transazioni
    • 06 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 30 mag 1997
    Consegnato il 02 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    The property at 2 the square stockley park all buildings plant and machinery all moneys standing to the credit of the security accounts all benefit in respect of the insurances the benefit of all licences and by way of assignment all rental income all rights under each development document all rental income payable under each agreement for lease all buildings and fixtures and the proceeds of sale and the benefit of any covenants for title.
    Persone aventi diritto
    • The Sakura Bank Limited
    Transazioni
    • 02 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security document
    Creato il 24 ott 1995
    Consegnato il 27 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) except for any obligations which,if it were so included,would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    The property at 3 the square,stockley park and all plant and machinery on the property and its interest in any plant or machinery on the property in its possession.all monies standing to the credit of the security accounts and the debts represented by them. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Sumitomo Bank,Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sksp Limited and Prudential Property Investments Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further supplemental agreement
    Creato il 17 apr 1991
    Consegnato il 18 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 6,600,000 due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    An account with universities superannuation scheme limited's bankers in england in "uss's" sole name but designated re -"stockley park-local authority guarantee.".
    Persone aventi diritto
    • Universities Superannuation Scheme Limited.
    Transazioni
    • 18 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assingnment deed of variation
    Creato il 28 set 1989
    Consegnato il 13 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For varying the terms of the original assingnment dated 20.7.89.
    Brevi particolari
    All the companys right title & interest in the contract moneys.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 set 1989
    Consegnato il 13 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for the banks, under the terms of the facility letter dated 20-7-88 as varied and supplemented.
    Brevi particolari
    F/H land being land on the south side of horton lane title no.MX209264, together with all buildings, fixtures & fittings, including trade fixtures; fixed plant and machinery. (For full details see doc M44L).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental mortgage
    Creato il 28 set 1989
    Consegnato il 13 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for the banks, under the terms of the facility letter dated 20-7-88 as varied & supplemented
    Brevi particolari
    Various properties listed on schedule to doc M45L together with all buildings, fixtures & fittings, including trade fixtures fixed plant and machinery. (For full details see doc M45L).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental debenture
    Creato il 28 set 1989
    Consegnato il 13 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the banks, including further advances, under the terms of the original facility letter dated 20-7-88 as varied & supplemented
    Brevi particolari
    Floating charge over the revenue, rights and benefit and heritable property and assets in scotland.. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental assignment
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 14 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a revised facility letter dated 10.5.89 and the charge
    Brevi particolari
    All the companys right, title & interest in respect of the contract inc, all claims & damages (for details see doc 395 ref M69).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 14 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a revised facility letter dated 10.5.89 & the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental mortgage
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 14 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of a revised facility letter dated 10.5.89
    Brevi particolari
    All the f/h property described in the first schedule with all fixtures & fittings refer to doc 395 ref M68.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 05 ott 1988
    Consegnato il 18 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 20-7-88
    Brevi particolari
    All the company's right, title & interest in the contract monies & all benefits & rights in respect of the said monies. (Please see form 395-M120-for details.).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ott 1988
    Consegnato il 18 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 20-7-88.
    Brevi particolari
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1988
    Consegnato il 18 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 20-7-88
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage various pieces of f/h and l/h land (as listed in schedule to form 395-M118) together with all buildings erected thereon, all additions alterations & improvements; all fixtures fittings including trade fixtures & fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    STOCKLEY PARK CONSORTIUM LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 feb 2016Inizio della liquidazione
    23 apr 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0