AMEY DATEL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AMEY DATEL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02254918 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AMEY DATEL LIMITED?
- Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
- Attività di amministrazione pubblica generale (84110) / Amministrazione pubblica e difesa; previdenza sociale obbligatoria
Dove si trova AMEY DATEL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AMEY DATEL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DATEL RAIL SYSTEMS LIMITED | 07 lug 1998 | 07 lug 1998 |
| DATEL SOFTWARE LIMITED | 03 nov 1988 | 03 nov 1988 |
| COMPUTING DESIGN LIMITED | 10 mag 1988 | 10 mag 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AMEY DATEL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per AMEY DATEL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Latham Nelson il 25 nov 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Birch il 16 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Birch come amministratore in data 15 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Lee Milner come amministratore in data 12 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 02 set 2019 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Amey Ow Limited come persona con controllo significativo il 02 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB in data 02 set 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Melvyn Ewell come amministratore in data 31 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AMEY DATEL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Amministratore | 142 Speke Road L19 2PH Liverpool The Matchworks England England | United Kingdom | British | 76116640004 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Amministratore | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| HUI, Carol | Segretario | GU8 | British | 72371980001 | ||||||||||
| LAWTON, Graham | Segretario | 25 Alder Grove FY6 8EJ Poulton Le Fylde Lancashire | British | 2382160001 | ||||||||||
| PUGH, Graham John | Segretario | The Windmill Mill Lane Wrea Green PR4 2WP Preston Lancashire | British | 24512450001 | ||||||||||
| SMITH, Michael John | Segretario | 63 Fields Road Haslingden BB4 6QA Rossendale Lancashire | British | 61711420001 | ||||||||||
| TETLOW, John Richard | Segretario | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 68445840001 | ||||||||||
| ADAMS, Richard Hawthorn | Amministratore | Bramley Cottage Coppice Hill Chalford GL6 8DZ Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 56940900001 | |||||||||
| BATCHELOR, Graeme Warwick | Amministratore | 2 Brookway Wrea Green PR4 2NU Preston Lancashire | British | 58892340002 | ||||||||||
| BRADBURY, Richard George | Amministratore | Beech Cottage Beech Lane WA6 6LP Norley Cheshire | British | 42234330002 | ||||||||||
| CORCORAN, Paul | Amministratore | 2 Cohen Close Chilwell NG9 6RW Nottingham | United Kingdom | British | 104822330002 | |||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Amministratore | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Amministratore | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| EWELL, Melvyn | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 61515760002 | |||||||||
| FARRER, Andrew Peter | Amministratore | 21 Upper Westby Avenue Lytham St Annes FY8 5NH Lancashire | British | 56447940002 | ||||||||||
| FENTON, Christopher Victor | Amministratore | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire | England | British | 114610580002 | |||||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Amministratore | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||||||
| LEO, Jose | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | 93348510004 | ||||||||||
| MCHALE, Damian | Amministratore | 5 Earle Close TS15 9SN Yarm Cleveland | British | 122992530001 | ||||||||||
| MILLER, David John | Amministratore | 1 Asmara Road NW2 3SS London | United Kingdom | British | 152304230002 | |||||||||
| MILNER, Andrew Lee | Amministratore | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building | England | British | 133714170002 | |||||||||
| MOGG, Charles Michael | Amministratore | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 87961010001 | ||||||||||
| MURAD, Simon William | Amministratore | The Rookeries Roundabout Copse RH20 2RB West Chiltington West Sussex | United Kingdom | British | 75114990001 | |||||||||
| PEAT, Stephen Hedley | Amministratore | 25 Canynge Square Clifton BS8 3LB Bristol Avon | British | 70137370001 | ||||||||||
| POWERS, Glenn Patrick | Amministratore | 23 Sefton Drive M28 2NG Worsley Manchester | British | 72486520001 | ||||||||||
| PUGH, Graham John | Amministratore | The Windmill Mill Lane Wrea Green PR4 2WP Preston Lancashire | British | 24512450001 | ||||||||||
| REEVES, William Thomas | Amministratore | 3 The Coppins Wildwood ST17 4QB Stafford Staffordshire | British | 93316550001 | ||||||||||
| ROBINSON, John Hamilton | Amministratore | Bull Rush House 8 Kennett Place Chilton Foliat RG17 0TB Hungerford Berkshire | American | 69410760003 | ||||||||||
| ROWAN, Darren | Amministratore | 37 Leach Lane FY8 3AN Lytham St Annes Lancashire | British | 59425480001 | ||||||||||
| SIMPSON, Alan Keith | Amministratore | 4 Riversleigh Avenue FY8 5QZ Lytham St Annes Lancashire | British | 34652910001 | ||||||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Amministratore | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 55479560003 | |||||||||
| SWEENEY, John Trevor | Amministratore | 6 Scarlet Oaks Portsmouth Road GU15 1RD Camberley Surrey | British | 70137390001 | ||||||||||
| WEBSTER, Christopher Charles | Amministratore | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 154210550001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di AMEY DATEL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amey Ow Limited | 06 apr 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
AMEY DATEL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Creato il 14 mar 2003 Consegnato il 26 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 ago 1998 Consegnato il 05 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0