TECNO RETAIL LIMITED

TECNO RETAIL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTECNO RETAIL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02256271
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TECNO RETAIL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TECNO RETAIL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TECNO RETAIL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHADOW GB LIMITED11 lug 198811 lug 1988
    FORGEFIRST LIMITED11 mag 198811 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di TECNO RETAIL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per TECNO RETAIL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 giu 2012

    Stato del capitale al 01 giu 2012

    • Capitale: GBP 3,544,963
    SH01

    Cessazione della carica di Nicholas Molyneux come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Hannan come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Sean Emmett come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Chris Yates come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di David Cashman come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Hannan come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di William Rollason come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Cashman come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2009 al 31 dic 2009

    1 pagineAA01

    legacy

    9 pagineMG01

    legacy

    11 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di TECNO RETAIL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOYDELL, Joanna
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish164373820001
    EMMETT, Sean Robert
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish152701300001
    YATES, Chris
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish165227300001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British48224770001
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    British93529300001
    SPRATLEY, James Peter Conway
    19 Beaconsfield Road
    St Margarets
    TW1 3HX Twickenham
    Segretario
    19 Beaconsfield Road
    St Margarets
    TW1 3HX Twickenham
    British28862210003
    BARRON, Paul
    Little Copse
    Knowle Grove
    GU25 4JD Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Little Copse
    Knowle Grove
    GU25 4JD Virginia Water
    Surrey
    Irish42811080001
    BINGER, David Ernest
    Wood End Firthsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Wood End Firthsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British9897020001
    BRITTEN, John Fletcher
    Gracious Pond Farm
    Gracious Pond Road
    GU24 8HL Chobham
    Surrey
    Amministratore
    Gracious Pond Farm
    Gracious Pond Road
    GU24 8HL Chobham
    Surrey
    British103341450001
    CASHMAN, David Peter Charles
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish151553190001
    COLLIER, Richard John
    Spencer House 14 West End
    Welford
    NN6 6HJ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Spencer House 14 West End
    Welford
    NN6 6HJ Northampton
    Northamptonshire
    British68393200003
    COULSON, Francis Archer
    West Dullater
    FK17 8HG Callander
    Perthshire
    Amministratore
    West Dullater
    FK17 8HG Callander
    Perthshire
    United KingdomBritish56397070001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish48224770001
    DUNSTONE, Charles William
    84 Campden Street
    W8 7EN London
    Amministratore
    84 Campden Street
    W8 7EN London
    British43842070001
    EVANS, Nicholas Gareth
    3 Kingsmead
    Edlesborough
    LU6 2JN Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    3 Kingsmead
    Edlesborough
    LU6 2JN Dunstable
    Bedfordshire
    British24811140001
    FAY, Anthony William
    Gatesdene House Gatesdene Close
    Little Gaddesden
    HP4 1PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gatesdene House Gatesdene Close
    Little Gaddesden
    HP4 1PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish5690480002
    FRYATT, Andrew Robert
    Garden Cottage
    Kenswick, Lower Broadheath
    WR2 6QX Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Garden Cottage
    Kenswick, Lower Broadheath
    WR2 6QX Worcester
    Worcestershire
    British71780340001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    British105128310002
    GRAY, Ian Archie
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    Amministratore
    6 Baronsmead Road
    SW13 9RR London
    EnglandBritish115801110001
    GUTTERIDGE, John
    1 The Avenue
    MK45 2NR Ampthill
    Bedfordshire
    Amministratore
    1 The Avenue
    MK45 2NR Ampthill
    Bedfordshire
    EnglandBritish70170890001
    HANNAN, Andrew
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish153976980001
    HARLING, Michael John
    71 Kings Road
    HP8 4HN Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    71 Kings Road
    HP8 4HN Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British29229870001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HENLEY, David Henry
    4 St Nicholas Close
    Tingrith
    MK17 9EL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 St Nicholas Close
    Tingrith
    MK17 9EL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British64485210001
    HINE, Derek Leslie
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    Amministratore
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    United KingdomBritish61935280001
    JOHNSON, David Arthur
    23 Balmoral Close
    GU34 1QY Alton
    Hampshire
    Amministratore
    23 Balmoral Close
    GU34 1QY Alton
    Hampshire
    British28862240001
    MCHUGH, Frank
    9 Maidenhair Drive
    CV23 0SE Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    9 Maidenhair Drive
    CV23 0SE Rugby
    Warwickshire
    British47650310001
    RICHER, Julian
    The Pent House
    68 Pall Mall
    SW1Y 5ES London
    Amministratore
    The Pent House
    68 Pall Mall
    SW1Y 5ES London
    United KingdomBritish61006910002
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Amministratore
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritish67354680003
    SAINSBURY, Stephen Paul
    20 Manor Court
    Manor Road
    TW2 5DL Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    20 Manor Court
    Manor Road
    TW2 5DL Twickenham
    Middlesex
    British72581570001
    SPRATLEY, James Peter Conway
    19 Beaconsfield Road
    St Margarets
    TW1 3HX Twickenham
    Amministratore
    19 Beaconsfield Road
    St Margarets
    TW1 3HX Twickenham
    British28862210003
    URRY, Julian
    56 Westgate
    Tickhill
    DN11 9NQ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    56 Westgate
    Tickhill
    DN11 9NQ Doncaster
    South Yorkshire
    British43066640001

    TECNO RETAIL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 29 set 2009
    Consegnato il 06 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 29 set 2009
    Consegnato il 02 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite debenture
    Creato il 30 ago 2007
    Consegnato il 17 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A supplemental deed
    Creato il 07 giu 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2007
    Consegnato il 19 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 set 1999
    Consegnato il 10 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lease security deposit agreement
    Creato il 21 set 1998
    Consegnato il 25 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    £12,054 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All money standing to the credit of the interest bearing account at barclays bank PLC in the name of vodafone group services limited.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Retail Limited
    Transazioni
    • 25 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 dic 1997
    Consegnato il 06 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 giu 1993
    Consegnato il 21 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 gen 1991
    Consegnato il 29 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an guarantee of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Diana Marilyn Britten
    • Johnstone Fletcher Britten
    Transazioni
    • 29 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 28 apr 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 mag 1990
    Consegnato il 30 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TECNO RETAIL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2024Conclusione della liquidazione
    19 apr 2013Data della petizione
    29 mag 2024Data prevista di scioglimento
    17 giu 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Leicester
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester
    Praticante
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0