CNC (CITY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCNC (CITY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02257640
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CNC (CITY) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova CNC (CITY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor The Atrium
    31 Church Road
    TW15 2UD Ashford
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CNC (CITY) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    QUICKNEAT LIMITED13 mag 198813 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di CNC (CITY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CNC (CITY) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CNC (CITY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2016

    19 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagine4.72

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 28 giu 2013

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 31 mag 2013

    2 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2015

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 mar 2014

    13 pagine4.68

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività

    4.20

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor the Atrium Ashford Middlesex TW15 2UD England* in data 20 mar 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    legacy

    4 pagineLQ01

    legacy

    4 pagineLQ01

    legacy

    3 pagineLQ01

    legacy

    4 pagineLQ01

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2012

    Stato del capitale al 23 gen 2012

    • Capitale: GBP 5,000,000
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Marie Annick Avis il 30 apr 2010

    2 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    12 pagineMG06

    legacy

    9 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CNC (CITY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AVIS, Marie Annick
    Brook Hill
    Farley Green Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Hill
    Farley Green Albury
    GU5 9DN Guildford
    Barn Cottage
    Surrey
    United Kingdom
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Amministratore
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Amministratore
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    AVIS, Marie Annick
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    Segretario
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    British91430630002
    BLACKETT, Kathleen
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Sanderling Cottage
    8 Llanvair Close
    SL5 9HX South Ascot
    Berkshire
    British1501820001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    12 Bonser Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RG Twickenham
    Middlesex
    British2667400001
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Segretario
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    CARDEN-NOAD, Stephen Mark
    7 Coney Close
    Langley Green
    RH11 7QA Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    7 Coney Close
    Langley Green
    RH11 7QA Crawley
    West Sussex
    British15950300001
    HAVER, Raymond Victor
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    Amministratore
    21 Denehurst Gardens
    IG8 0PA Woodford Green
    Essex
    British15226710001
    JOHNSTON, James Vincent
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    18 Testwood Road
    SL4 5RW Windsor
    Berkshire
    British35134150001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Amministratore
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    NEDHAM, Andrew James
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    Amministratore
    8 Furzedown Close
    TW20 9PY Egham
    Surrey
    British66426700001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Amministratore
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    VINCENT, Gregory
    2 The Limes
    Sarson Lane, Amport
    SP11 8HX Andover
    Hampshire
    Amministratore
    2 The Limes
    Sarson Lane, Amport
    SP11 8HX Andover
    Hampshire
    EnglandBritish65461840001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002

    CNC (CITY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental mortgage
    Creato il 23 dic 2010
    Consegnato il 07 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged property means the real property - f/h land at the north seaton estate, ashington, northumberland t/no ND102631.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 07 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 202 giu 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
      • Numero di pratica 2
    Fixed and floating security document
    Creato il 26 set 2009
    Acquisito il 23 dic 2010
    Consegnato il 12 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Real property means the f/h land at the north seaton estate, ashington, northumberland t/no ND102631 including fixtures, plant, machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 12 gen 2011Registrazione di un'acquisizione (MG06)
    Fixed and floating security document
    Creato il 26 ago 2009
    Consegnato il 01 set 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Britannia house spring street 2 ferensway kingston upon hull t/no HS120963, land lying south of wansbeck district hospital t/no ND102630, 9 castle street cardiff t/no WA448850 (for details of further properties charged please refer to the form 395); fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 01 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 102 giu 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 329 giu 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 410 lug 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 413 ott 2015Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 4
      • Numero di pratica 1
      • Numero di pratica 3
    Share charge
    Creato il 02 lug 2009
    Consegnato il 20 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee and/or the hedging counterparty and/or ant associated company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments including all rights of enforcement of the same- being the interest of the chargor in one ordinary share of the borrower see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating security document
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal charge
    Creato il 18 nov 2003
    Consegnato il 27 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being plot 29 heol stanlydd cross hands business park cross hands llanelli t/n CYM125557. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 set 2001
    Consegnato il 20 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    9 castle street and 11 castle st,cardiff; WA448850 and WA448854. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 giu 2001
    Consegnato il 03 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land on the south side of hamm moor lane chertsey t/n SY700701 and SY700762. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2000
    Consegnato il 26 lug 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the senior finance documents (or any of them) to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Agent)
    Transazioni
    • 26 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Standard security presented for registration in scotland 21ST july 2000
    Creato il 10 lug 2000
    Consegnato il 03 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for itself and the finance parties) and to any of the finance parties (as defined) by each charging company and any of the obligors under the senior credit agreement dated 18TH may 2000 including any agreement,deed or other document supplemental thereto or in corroboration or in substitution thereof
    Brevi particolari
    Subject on the southwest side of stirling road airdrie t/n LAN77108.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 21ST july 2000
    Creato il 10 lug 2000
    Consegnato il 03 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for itself and the finance parties) and to any of the finance parties (as defined) by each charging company and any of the obligors under the senior credit agreement dated 18TH may 2000 including any agreement,deed or other document supplemental thereto or in corroboration or in substitution thereof
    Brevi particolari
    All and whole the subjects lying on the north west side of woodrow avenue carfin t/n LAN87412.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 21ST july 2000
    Creato il 10 lug 2000
    Consegnato il 03 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due,owing or incurred to the chargee (as security agent and trustee for itself and the finance parties) and to any of the finance parties (as defined) by each charging company and any of the obligors under the senior credit agreement dated 18TH may 2000 including any agreement,deed or other document supplemental thereto or in corroboration or in substitution thereof
    Brevi particolari
    Subject on the north side of the A8 at westferry langbank port glasgow t/n ren 33227.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 giu 1999
    Consegnato il 09 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a nene house 10/12 pilgrim street newcastle upon tyne. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the legal charge dated 31ST march 1994
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of waterlinks house richard street heartlands birmingham. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 1996
    Consegnato il 12 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Queens house 2 holly road twickenham middx t/no mx 447624 with the goodwill of the business and. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 80/80A fenchurch street london EC3 t/n LN62407, fixed charge the goodwill and assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 34/36 st georges road brighton east sussex t/n's SX112752, SX114788 and SX109674, fixed charge all goodwill and assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 3 queen's circus cheltenham gloucestershire, fixed charge all goodwill, assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 22 imperial square cheltenham gloucestershire, fixed charge all goodwill, assigns benefits of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a victoria house 18-22 albert street fleet hampshire t/n HP347533, fixed charge the goodwill, assigns benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 4 st george's place brighton east sussex t/n ESX24677, fixed charge all goodwill, assigns benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1994
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land lying to the south east of london road westerham (otherwise k/a the westerham trading centre flyers way london road westerham kent) t/n K536959, fixed charge all goodwill, assigns the benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1994
    Consegnato il 08 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:-parsons house parsons road parsons washington sunderland tyne & wear goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 01 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage;-emerald house,30/38 high street byfleet surrey goodwill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 mag 1994
    Consegnato il 13 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Cnc house 33 high street sunninghill ascot berkshire the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CNC (CITY) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    4Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Louisa Jane Brooks
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Jonathan Howard Gershinson
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    Ricevitore/gestore
    33 Wigmore Street
    W1U 1BZ London
    5
    DataTipo
    07 mar 2013Inizio della liquidazione
    29 set 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0