WSP NORTH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWSP NORTH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02257665
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WSP NORTH LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WSP NORTH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wsp House
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WSP NORTH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WSP KENCHINGTON FORD (NORTH) LIMITED29 nov 199329 nov 1993
    WSP CONSULTING ENGINEERS (NEWCASTLE) LIMITED07 gen 199307 gen 1993
    CAIRNS & BYLES LIMITED15 giu 198815 giu 1988
    YULARA LIMITED13 mag 198813 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di WSP NORTH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per WSP NORTH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Amber Court William Armstrong Drive Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YQ England a Wsp House Chancery Lane London WC2A 1AF

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF

    1 pagineAD04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Andrew Christopher John Noble come amministratore in data 02 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Miles Lawrence Barnard come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Karen Anne Sewell come segretario in data 15 dic 2016

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Mark William Naysmith come amministratore in data 15 dic 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Nabarro Llp 1 South Quay Victoria Quays Sheffield South Yorkshire S2 5SY England a Amber Court William Armstrong Drive Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YQ

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 lug 2015

    Stato del capitale al 06 lug 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Cessazione della carica di Christopher Cole come amministratore in data 20 ott 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Christopher John Noble come amministratore in data 20 ott 2014

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2014

    Stato del capitale al 23 giu 2014

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Chi sono gli amministratori di WSP NORTH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SEWELL, Karen Anne
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Segretario
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    220969450001
    BARNARD, Miles Lawrence
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    EnglandBritishFinance Director225925270001
    NAYSMITH, Mark William
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    ScotlandBritishCivil Engineer79793020003
    BISSET, Graham Ferguson
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United Kingdom
    Segretario
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United Kingdom
    British56857830001
    BYLES, Peter Scott
    11 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    11 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    British11927910001
    HAGUES, Ian James
    Green Pastures
    Lands Lane
    HG5 9DE Knaresborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Green Pastures
    Lands Lane
    HG5 9DE Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishAccountant4249040001
    MARTIN, Christopher Charles
    Ground Floor Flat 27 Garfield Road
    Chingford
    E4 7DG London
    Segretario
    Ground Floor Flat 27 Garfield Road
    Chingford
    E4 7DG London
    British43568800001
    MORRIS, Simon John
    271 Bury Road
    Tottington
    BL8 3DY Bury
    Lancashire
    Segretario
    271 Bury Road
    Tottington
    BL8 3DY Bury
    Lancashire
    British40115610003
    PAUL, Malcolm Stephen
    Kimberley 4 Grove Shaw
    Kingswood Court
    KT20 6QL Tadworth
    Surrey
    Segretario
    Kimberley 4 Grove Shaw
    Kingswood Court
    KT20 6QL Tadworth
    Surrey
    BritishChartered Accountant3865030001
    BELL, Brian Trevor
    3 Rocksprings Crescent
    Haydon Bridge
    NE47 6AT Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    3 Rocksprings Crescent
    Haydon Bridge
    NE47 6AT Hexham
    Northumberland
    BritishCivil Engineer51447920001
    BYLES, Peter Scott
    11 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    11 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    BritishConsulting Engineer11927910001
    CAMPBELL, Stephen Alan
    15 Boissy Close
    AL4 0UE St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    15 Boissy Close
    AL4 0UE St. Albans
    Hertfordshire
    BritishChartered Engineer80109580001
    COLE, Christopher
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United Kingdom
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Engineer39376270004
    COLE, Christopher
    10 Meade Court
    Walton Street
    KT20 7RN Walton On The Hill
    Surrey
    Amministratore
    10 Meade Court
    Walton Street
    KT20 7RN Walton On The Hill
    Surrey
    BritishConsulting Engineer39376270001
    DRENON, Peter
    Park House
    Slaley
    NE47 0BQ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Park House
    Slaley
    NE47 0BQ Hexham
    Northumberland
    BritishConsulting Egineer51447690002
    FARRER, Martin Nigel
    7 Trinity Terrace
    NE45 5HW Corbridge
    Northumberland
    Amministratore
    7 Trinity Terrace
    NE45 5HW Corbridge
    Northumberland
    EnglandBritishCivil Engineer51447890002
    FROST, Anthony Wood
    Inkles Haugh Stable Green
    Mitford
    NE61 3QA Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Inkles Haugh Stable Green
    Mitford
    NE61 3QA Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector12616610001
    GILL, Peter Richard
    30 Sheen Common Drive
    TW10 5BN Richmond
    Surrey
    Amministratore
    30 Sheen Common Drive
    TW10 5BN Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant35996320004
    GREENBECK, John Michael Howard
    53 Kenton Lane
    NE3 3BS Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    53 Kenton Lane
    NE3 3BS Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishConsulting Engineer87223690001
    HARMER, Barrie
    18 Becketts Close
    Heptonstall
    HX7 7LJ Hebden Bridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    18 Becketts Close
    Heptonstall
    HX7 7LJ Hebden Bridge
    West Yorkshire
    BritishConsulting Engineer37430060002
    LADKIN, David
    Fell House
    Birney Hill
    NE15 9RB Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Fell House
    Birney Hill
    NE15 9RB Newcastle Upon Tyne
    BritishCivil Engineer51447860001
    LAVERICK, Malcolm
    44 Megstone Avenue
    NE23 6TU Cramlington
    Northumberland
    Amministratore
    44 Megstone Avenue
    NE23 6TU Cramlington
    Northumberland
    BritishConsulting Engineer11927920001
    LOOKER, Kevin Charles
    3 Matthew Bank
    Jesmond
    NE2 3QY Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    3 Matthew Bank
    Jesmond
    NE2 3QY Newcastle Upon Tyne
    BritishConsulting Engineer57234360001
    MARSHALL, Paul Lindsay
    20 Ettrick Grove
    SR4 8PZ Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    20 Ettrick Grove
    SR4 8PZ Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishConsulting Engineer44080730001
    MILLINGTON, James
    24 Welbury Way
    NE23 6PE Cramlington
    Northumberland
    Amministratore
    24 Welbury Way
    NE23 6PE Cramlington
    Northumberland
    BritishConsulting Engineer12144150001
    MORRIS, Simon John
    271 Bury Road
    Tottington
    BL8 3DY Bury
    Lancashire
    Amministratore
    271 Bury Road
    Tottington
    BL8 3DY Bury
    Lancashire
    BritishChartered Accountant40115610003
    NESBITT, Alan Maddison
    16 Cedar Drive
    DH1 3TF Durham
    County Durham
    Amministratore
    16 Cedar Drive
    DH1 3TF Durham
    County Durham
    United KingdomBritishCivil Engineer21443920001
    NEWELL, David
    College Barn 120 High Street
    Long Crendon
    HP18 9AN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    College Barn 120 High Street
    Long Crendon
    HP18 9AN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishConsulting Engineer20933370001
    NOBLE, Andrew Christopher John
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United KingdomBritishChartered Accountant192017410001
    O'BRIEN, Michael John
    1 Hopcraft Lane
    OX15 0TD Deddington
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 Hopcraft Lane
    OX15 0TD Deddington
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector73162250001
    OGUNSHAKIN, Olawale Nelson, Dr
    2 Campion Grove
    B63 1HB Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    2 Campion Grove
    B63 1HB Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritishDirector79430120001
    PAGE, Andrew Smith
    14 Broomhead Park
    KY12 0PT Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    14 Broomhead Park
    KY12 0PT Dunfermline
    Fife
    BritishConsulting Engineer34629060001
    PAUL, Malcolm Stephen
    Staplefield Road
    Cuckfield
    RH17 5HY Haywards Heath
    Henmead Hall
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Staplefield Road
    Cuckfield
    RH17 5HY Haywards Heath
    Henmead Hall
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant3865030002
    PAUL, Malcolm Stephen
    Kimberley 4 Grove Shaw
    Kingswood Court
    KT20 6QL Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Kimberley 4 Grove Shaw
    Kingswood Court
    KT20 6QL Tadworth
    Surrey
    BritishDirector3865030001
    ROSE, James
    Meadowview Cottage
    Townend Court
    YO26 9RD Great Ouseburn
    York
    Amministratore
    Meadowview Cottage
    Townend Court
    YO26 9RD Great Ouseburn
    York
    BritishConsultant Engineer75632930001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WSP NORTH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wsp Group Limited
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    06 apr 2016
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Liabiability Company
    Autorità legaleEngland And Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WSP NORTH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 04 lug 2001
    Consegnato il 06 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due by each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) and all obligations and liabilities whatsoever of each company listed in schedule 1 to the chargor's security agreement (as defined) as chargors to barclays bank PLC (the "facility agent") under the £2,000,000 bonding and letter of credit facility (as defined) between wsp group PLC and barclays bank PLC dated 25TH june 2001,but only up to an aggregate maximum of £2,000,000
    Brevi particolari
    First legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by the chargor and by way of first fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property with all buildings,fixtures,fittings and fixed plant and machinery thereon; the benefit of any covenants for title given or any moneys payable in respect of the covenants; first legal mortgage over the shares in any member group and by way of first fixed charge over all shares,stocks,debentures,bonds or other securities and investments; all book and other debts and all other moneys due and benefit of all rights,securities or guarantees whatsoever; first floating charge over all assets; see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 giu 1992
    Consegnato il 24 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0