WSP NORTH LIMITED
Panoramica
Nome della società | WSP NORTH LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02257665 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WSP NORTH LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova WSP NORTH LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Wsp House 70 Chancery Lane WC2A 1AF London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WSP NORTH LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WSP KENCHINGTON FORD (NORTH) LIMITED | 29 nov 1993 | 29 nov 1993 |
WSP CONSULTING ENGINEERS (NEWCASTLE) LIMITED | 07 gen 1993 | 07 gen 1993 |
CAIRNS & BYLES LIMITED | 15 giu 1988 | 15 giu 1988 |
YULARA LIMITED | 13 mag 1988 | 13 mag 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WSP NORTH LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per WSP NORTH LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Amber Court William Armstrong Drive Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YQ England a Wsp House Chancery Lane London WC2A 1AF | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Christopher John Noble come amministratore in data 02 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Miles Lawrence Barnard come amministratore in data 01 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Karen Anne Sewell come segretario in data 15 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark William Naysmith come amministratore in data 15 dic 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Nabarro Llp 1 South Quay Victoria Quays Sheffield South Yorkshire S2 5SY England a Amber Court William Armstrong Drive Newcastle Business Park Newcastle upon Tyne NE4 7YQ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Cole come amministratore in data 20 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Christopher John Noble come amministratore in data 20 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WSP NORTH LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEWELL, Karen Anne | Segretario | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | 220969450001 | |||||||
BARNARD, Miles Lawrence | Amministratore | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | England | British | Finance Director | 225925270001 | ||||
NAYSMITH, Mark William | Amministratore | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | Scotland | British | Civil Engineer | 79793020003 | ||||
BISSET, Graham Ferguson | Segretario | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House United Kingdom | British | 56857830001 | ||||||
BYLES, Peter Scott | Segretario | 11 Westfield Grove Gosforth NE3 4YA Newcastle Upon Tyne | British | 11927910001 | ||||||
HAGUES, Ian James | Segretario | Green Pastures Lands Lane HG5 9DE Knaresborough North Yorkshire | British | Accountant | 4249040001 | |||||
MARTIN, Christopher Charles | Segretario | Ground Floor Flat 27 Garfield Road Chingford E4 7DG London | British | 43568800001 | ||||||
MORRIS, Simon John | Segretario | 271 Bury Road Tottington BL8 3DY Bury Lancashire | British | 40115610003 | ||||||
PAUL, Malcolm Stephen | Segretario | Kimberley 4 Grove Shaw Kingswood Court KT20 6QL Tadworth Surrey | British | Chartered Accountant | 3865030001 | |||||
BELL, Brian Trevor | Amministratore | 3 Rocksprings Crescent Haydon Bridge NE47 6AT Hexham Northumberland | British | Civil Engineer | 51447920001 | |||||
BYLES, Peter Scott | Amministratore | 11 Westfield Grove Gosforth NE3 4YA Newcastle Upon Tyne | British | Consulting Engineer | 11927910001 | |||||
CAMPBELL, Stephen Alan | Amministratore | 15 Boissy Close AL4 0UE St. Albans Hertfordshire | British | Chartered Engineer | 80109580001 | |||||
COLE, Christopher | Amministratore | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House United Kingdom | England | British | Chartered Engineer | 39376270004 | ||||
COLE, Christopher | Amministratore | 10 Meade Court Walton Street KT20 7RN Walton On The Hill Surrey | British | Consulting Engineer | 39376270001 | |||||
DRENON, Peter | Amministratore | Park House Slaley NE47 0BQ Hexham Northumberland | British | Consulting Egineer | 51447690002 | |||||
FARRER, Martin Nigel | Amministratore | 7 Trinity Terrace NE45 5HW Corbridge Northumberland | England | British | Civil Engineer | 51447890002 | ||||
FROST, Anthony Wood | Amministratore | Inkles Haugh Stable Green Mitford NE61 3QA Morpeth Northumberland | British | Director | 12616610001 | |||||
GILL, Peter Richard | Amministratore | 30 Sheen Common Drive TW10 5BN Richmond Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 35996320004 | ||||
GREENBECK, John Michael Howard | Amministratore | 53 Kenton Lane NE3 3BS Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Consulting Engineer | 87223690001 | ||||
HARMER, Barrie | Amministratore | 18 Becketts Close Heptonstall HX7 7LJ Hebden Bridge West Yorkshire | British | Consulting Engineer | 37430060002 | |||||
LADKIN, David | Amministratore | Fell House Birney Hill NE15 9RB Newcastle Upon Tyne | British | Civil Engineer | 51447860001 | |||||
LAVERICK, Malcolm | Amministratore | 44 Megstone Avenue NE23 6TU Cramlington Northumberland | British | Consulting Engineer | 11927920001 | |||||
LOOKER, Kevin Charles | Amministratore | 3 Matthew Bank Jesmond NE2 3QY Newcastle Upon Tyne | British | Consulting Engineer | 57234360001 | |||||
MARSHALL, Paul Lindsay | Amministratore | 20 Ettrick Grove SR4 8PZ Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Consulting Engineer | 44080730001 | ||||
MILLINGTON, James | Amministratore | 24 Welbury Way NE23 6PE Cramlington Northumberland | British | Consulting Engineer | 12144150001 | |||||
MORRIS, Simon John | Amministratore | 271 Bury Road Tottington BL8 3DY Bury Lancashire | British | Chartered Accountant | 40115610003 | |||||
NESBITT, Alan Maddison | Amministratore | 16 Cedar Drive DH1 3TF Durham County Durham | United Kingdom | British | Civil Engineer | 21443920001 | ||||
NEWELL, David | Amministratore | College Barn 120 High Street Long Crendon HP18 9AN Aylesbury Buckinghamshire | British | Consulting Engineer | 20933370001 | |||||
NOBLE, Andrew Christopher John | Amministratore | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 192017410001 | ||||
O'BRIEN, Michael John | Amministratore | 1 Hopcraft Lane OX15 0TD Deddington Oxfordshire | England | British | Director | 73162250001 | ||||
OGUNSHAKIN, Olawale Nelson, Dr | Amministratore | 2 Campion Grove B63 1HB Halesowen West Midlands | England | British | Director | 79430120001 | ||||
PAGE, Andrew Smith | Amministratore | 14 Broomhead Park KY12 0PT Dunfermline Fife | British | Consulting Engineer | 34629060001 | |||||
PAUL, Malcolm Stephen | Amministratore | Staplefield Road Cuckfield RH17 5HY Haywards Heath Henmead Hall West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 3865030002 | ||||
PAUL, Malcolm Stephen | Amministratore | Kimberley 4 Grove Shaw Kingswood Court KT20 6QL Tadworth Surrey | British | Director | 3865030001 | |||||
ROSE, James | Amministratore | Meadowview Cottage Townend Court YO26 9RD Great Ouseburn York | British | Consultant Engineer | 75632930001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WSP NORTH LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wsp Group Limited | 06 apr 2016 | 70 Chancery Lane WC2A 1AF London Wsp House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
WSP NORTH LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A security agreement | Creato il 04 lug 2001 Consegnato il 06 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities whatsoever due or to become due by each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) and all obligations and liabilities whatsoever of each company listed in schedule 1 to the chargor's security agreement (as defined) as chargors to barclays bank PLC (the "facility agent") under the £2,000,000 bonding and letter of credit facility (as defined) between wsp group PLC and barclays bank PLC dated 25TH june 2001,but only up to an aggregate maximum of £2,000,000 | |
Brevi particolari First legal mortgage over all estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by the chargor and by way of first fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property with all buildings,fixtures,fittings and fixed plant and machinery thereon; the benefit of any covenants for title given or any moneys payable in respect of the covenants; first legal mortgage over the shares in any member group and by way of first fixed charge over all shares,stocks,debentures,bonds or other securities and investments; all book and other debts and all other moneys due and benefit of all rights,securities or guarantees whatsoever; first floating charge over all assets; see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 giu 1992 Consegnato il 24 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0