CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02258845 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CROWN VEHICLE CONTRACTS PUBLIC LIMITED COMPANY | 28 giu 1988 | 28 giu 1988 |
| S W 112 COMPANY LIMITED | 17 mag 1988 | 17 mag 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Andrew Carter come amministratore in data 24 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Stato del capitale al 27 giu 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT10 | ||||||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 51 pagine | MAR | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata | 1 pagine | RR02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 52 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Katherine Dean come segretario in data 21 giu 2013 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Hollie Rheanna Wood come segretario in data 21 giu 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Richard Andrew Carter come amministratore in data 14 nov 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Adrian Timothy Rigby come amministratore in data 22 mag 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Robert Francis Carver come amministratore in data 22 mag 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gavin Paul Hewitt il 20 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAN, Katherine | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 179275100001 | |||||||
| CARVER, Robert Francis | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 167169940001 | |||||
| HEWITT, Gavin Paul | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 162283890002 | |||||
| RUSSELL-BROWN, Michael John | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 109954540001 | |||||
| BAYER, George William | Segretario | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Segretario | Guildford Grove SE10 8JT London 8 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Segretario | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Segretario | 8 Canada Square E14 5HQ London | British | 109247130002 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Segretario | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Segretario | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Segretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Segretario | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Segretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 161331380001 | |||||||
| BOTTOMLEY, Stephen Andrew | Amministratore | Liverton House Roundwood Lane RH16 1SJ Lindfield West Sussex | British | 60768490002 | ||||||
| BROOKES, Malcolm James | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 61727900006 | |||||
| CARTER, Richard Andrew | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 173634300001 | |||||
| CLAYTON, Leonard Francis | Amministratore | 5 The Crofts Banbury Road CV37 7NF Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 58398630002 | ||||||
| EVANS, Geoffrey William | Amministratore | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| FLETCHER, Nigel Norman | Amministratore | 9 Browns Coppice Avenue B91 Solihull West Midlands | British | 65375170001 | ||||||
| GILMAN, David William | Amministratore | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HARTLAND, John William | Amministratore | The Beeches Cleobury Road Far Forest Rock DY14 9TA Kidderminster Worcs | British | 27825190001 | ||||||
| HASKINS, Christopher John | Amministratore | 22 Four Acres Close Nailsea BS19 2YF Bristol Avon | British | 71713850001 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 12 Aspins Way Bromsgrove B61 0UW Birmingham | British | 28497420007 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Amministratore | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| HUGHES, Robert Kingston | Amministratore | Holmbush 35 Church Road BS25 1BJ Winscombe North Somerset | British | 58383940001 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Amministratore | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| LANE, Robert David | Amministratore | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| LEWIS, Barry Gordon | Amministratore | Fathom House 63 Whitesfield Road BS19 2NF Nailsea Avon | British | 33595340001 | ||||||
| OWENS, Gareth Mervyn | Amministratore | 52 Lowbrook Lane Tidbury Green B90 1QR Solihull | British | 27821120001 | ||||||
| PICKEN, Graham Edward | Amministratore | 60 Church Road Aspley Heath Woburn Sands MK17 8TA Milton Keynes | British | 144947830001 | ||||||
| QUINN, Noel Paul | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 123627420002 | |||||
| QUINN, Noel Paul | Amministratore | 10 Besford Grove Shirley B90 4YU Solihull West Midlands | British | 72093050001 | ||||||
| RIGBY, Adrian Timothy | Amministratore | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 138880420001 | |||||
| SMITHSON, Keith Victor | Amministratore | The Stables 3 Old Manor Court Welton NN11 5HA Daventry Northamptonshire | Irish | 72729280002 |
CROWN VEHICLE CONTRACTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit agreement | Creato il 26 feb 1991 Consegnato il 28 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 26TH july 1990 and this deed (as defined) | |
Brevi particolari The sum of sterling pounds 23,750 deposited in a designated premium rate deposit account at lloyds bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge. | Creato il 24 gen 1989 Consegnato il 28 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Master agreement & charge | Creato il 25 ago 1988 Consegnato il 13 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All sub-hiring agreements and all associated charges in action rights & securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0