CPI COMMERCIAL PRINT LTD

CPI COMMERCIAL PRINT LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCPI COMMERCIAL PRINT LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02262115
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    Indirizzo della sede legale
    8 Springfield Close
    Ovington
    NE42 6WZ Prudhoe
    Northumberland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FULMAR COLOUR PRINTING COMPANY LIMITED13 feb 198913 feb 1989
    CLEVERSWIFT LIMITED25 mag 198825 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2014

    Stato del capitale al 06 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Francois Golicheff come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading Berkshire RG1 8EX* in data 13 mar 2014

    1 pagineAD01

    Stato del capitale al 07 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed fulmar colour printing company LIMITED\certificate issued on 02/04/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name02 apr 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 apr 2012

    RES15
    change-of-name02 apr 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Matthew William Robson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Williams come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Michael Owen Williams come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Segretario
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    British93423100001
    ROBSON, Matthew William
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Reivers
    Northumberland
    England
    Amministratore
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Reivers
    Northumberland
    England
    EnglandBritish93423100001
    HARRIS, Derek John
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    Segretario
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    British14483180001
    TAYLOR, Frances Mary
    The Chantry Rectory Lane
    Brasted
    TN16 1NH Westerham
    Kent
    Segretario
    The Chantry Rectory Lane
    Brasted
    TN16 1NH Westerham
    Kent
    British10315300001
    BOVARD, Timothy Landon
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    Amministratore
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    British101457350001
    CATTE, Pierre Francois
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    Amministratore
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    FranceFrench165234830001
    COPSON, David Gary
    Beech House
    Mill Hill
    TN8 5DA Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Beech House
    Mill Hill
    TN8 5DA Edenbridge
    Kent
    EnglandBritish73882150004
    GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    Amministratore
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    FranceFrench146651780001
    GUILLIER TUAL, Natalie
    43 Bis Rue Henri Cloppet
    Le Vesinet
    78100
    France
    Amministratore
    43 Bis Rue Henri Cloppet
    Le Vesinet
    78100
    France
    French103508190001
    HARRIS, Derek John
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    Amministratore
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    United KingdomBritish14483180001
    IVEY, Alan Edward
    11 Hophurst Drive
    Crawley Down
    RH10 4XA Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    11 Hophurst Drive
    Crawley Down
    RH10 4XA Crawley
    West Sussex
    British14956370001
    MARLEY, Keith Anthony
    Stream View The Moorings
    Felbridge
    RH19 2RL East Grinstead
    West Sussex
    Amministratore
    Stream View The Moorings
    Felbridge
    RH19 2RL East Grinstead
    West Sussex
    EnglandBritish14956340002
    MCCULLOCH, John Ernest
    89 Upper Selsdon Road
    CR2 0DP South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    89 Upper Selsdon Road
    CR2 0DP South Croydon
    Surrey
    British14956360001
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Amministratore
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    EnglandBritish93423100001
    TAYLOR, Michael Edward
    Forest Hall Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Forest Hall Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish10315310003
    TYLER, Paul Joseph
    1 Farm Close
    IG9 5AJ Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    1 Farm Close
    IG9 5AJ Buckhurst Hill
    Essex
    British14956350001
    WHITLOCK, Kenneth Albert
    10 Fairway
    Merrow
    GU1 2XQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    10 Fairway
    Merrow
    GU1 2XQ Guildford
    Surrey
    British14481070001
    WILLIAMS, Michael Owen
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish198947630001

    CPI COMMERCIAL PRINT LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory guarantee & debenture
    Creato il 10 dic 2009
    Consegnato il 19 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch as Security Agent and as Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 19 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 12 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,Paris Branch,as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 12 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 29 ott 1997
    Consegnato il 29 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 used june 1995 heidelberg speedmaster 74 four colour offset press serial no. 620700, one used december 1995 heidelberg speedmaster 74 six colour offset press serial no. 321114, one used november 1995 heidelberg speedmaster 74 six colour offset press serial no. 621018 and one used july 1995 heidelberg speedmaster 74 six colour offset press serial no. 620651. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 29 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 06 mag 1997
    Consegnato il 14 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,700,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1X1995 heidelberg speedmaster 74 four colour offset press s/no 620 700, six colour offset press s/no 620 651, six colour offset press s/no 621 018, six colour offset press s/no 621 114.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 10 mar 1997
    Consegnato il 12 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,900,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1 x heidelberg speedmaster sm 102 four colour offset press model sm 102-4P3, 102 x 72CMS with perfector (2+2) cp tronic controlled serial no.538242. 1 x heidelberg carton speedmaster 102 six colour offset press model cd 102-6 72 x 102CMS cp tronic controlled serial no.538175. 1 x heidelberg carton speedmaster 102 six colour offset press model cd 102-6 72 x 102CMS cp tronic controlled serial no.538539. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 mar 1993
    Consegnato il 22 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1988 5 heidelberg 102F printing press with cpg 1-02 serial no 525758.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 ago 1989
    Consegnato il 16 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0