CPI COMMERCIAL PRINT LTD
Panoramica
| Nome della società | CPI COMMERCIAL PRINT LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02262115 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
Dove si trova CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
| Indirizzo della sede legale | 8 Springfield Close Ovington NE42 6WZ Prudhoe Northumberland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FULMAR COLOUR PRINTING COMPANY LIMITED | 13 feb 1989 | 13 feb 1989 |
| CLEVERSWIFT LIMITED | 25 mag 1988 | 25 mag 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Francois Golicheff come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading Berkshire RG1 8EX* in data 13 mar 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 07 mar 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed fulmar colour printing company LIMITED\certificate issued on 02/04/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Matthew William Robson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Williams come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Michael Owen Williams come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CPI COMMERCIAL PRINT LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON, Matthew William | Segretario | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | British | 93423100001 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Amministratore | Springfield Close NE42 6EL Ovington Reivers Northumberland England | England | British | 93423100001 | |||||
| HARRIS, Derek John | Segretario | 35 Furze Lane CR8 3EJ Purley Surrey | British | 14483180001 | ||||||
| TAYLOR, Frances Mary | Segretario | The Chantry Rectory Lane Brasted TN16 1NH Westerham Kent | British | 10315300001 | ||||||
| BOVARD, Timothy Landon | Amministratore | 7 Boulevard Anatole France FOREIGN Boulogne 92100 France | British | 101457350001 | ||||||
| CATTE, Pierre Francois | Amministratore | Bis Rue De La Tour 75016 Paris 62 France | France | French | 165234830001 | |||||
| COPSON, David Gary | Amministratore | Beech House Mill Hill TN8 5DA Edenbridge Kent | England | British | 73882150004 | |||||
| GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre | Amministratore | Cardiff Road RG1 8EX Reading Cox & Wyman House Berkshire | France | French | 146651780001 | |||||
| GUILLIER TUAL, Natalie | Amministratore | 43 Bis Rue Henri Cloppet Le Vesinet 78100 France | French | 103508190001 | ||||||
| HARRIS, Derek John | Amministratore | 35 Furze Lane CR8 3EJ Purley Surrey | United Kingdom | British | 14483180001 | |||||
| IVEY, Alan Edward | Amministratore | 11 Hophurst Drive Crawley Down RH10 4XA Crawley West Sussex | British | 14956370001 | ||||||
| MARLEY, Keith Anthony | Amministratore | Stream View The Moorings Felbridge RH19 2RL East Grinstead West Sussex | England | British | 14956340002 | |||||
| MCCULLOCH, John Ernest | Amministratore | 89 Upper Selsdon Road CR2 0DP South Croydon Surrey | British | 14956360001 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Amministratore | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | England | British | 93423100001 | |||||
| TAYLOR, Michael Edward | Amministratore | Forest Hall Springwood Park TN11 9LZ Tonbridge Kent | England | British | 10315310003 | |||||
| TYLER, Paul Joseph | Amministratore | 1 Farm Close IG9 5AJ Buckhurst Hill Essex | British | 14956350001 | ||||||
| WHITLOCK, Kenneth Albert | Amministratore | 10 Fairway Merrow GU1 2XQ Guildford Surrey | British | 14481070001 | ||||||
| WILLIAMS, Michael Owen | Amministratore | Fisher Green Binfield RG42 4EQ Bracknell 1 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 198947630001 |
CPI COMMERCIAL PRINT LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmatory guarantee & debenture | Creato il 10 dic 2009 Consegnato il 19 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 26 lug 2006 Consegnato il 12 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 29 ott 1997 Consegnato il 29 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1 used june 1995 heidelberg speedmaster 74 four colour offset press serial no. 620700, one used december 1995 heidelberg speedmaster 74 six colour offset press serial no. 321114, one used november 1995 heidelberg speedmaster 74 six colour offset press serial no. 621018 and one used july 1995 heidelberg speedmaster 74 six colour offset press serial no. 620651. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 06 mag 1997 Consegnato il 14 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,700,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 1X1995 heidelberg speedmaster 74 four colour offset press s/no 620 700, six colour offset press s/no 620 651, six colour offset press s/no 621 018, six colour offset press s/no 621 114. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 10 mar 1997 Consegnato il 12 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,900,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari 1 x heidelberg speedmaster sm 102 four colour offset press model sm 102-4P3, 102 x 72CMS with perfector (2+2) cp tronic controlled serial no.538242. 1 x heidelberg carton speedmaster 102 six colour offset press model cd 102-6 72 x 102CMS cp tronic controlled serial no.538175. 1 x heidelberg carton speedmaster 102 six colour offset press model cd 102-6 72 x 102CMS cp tronic controlled serial no.538539. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 16 mar 1993 Consegnato il 22 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari 1988 5 heidelberg 102F printing press with cpg 1-02 serial no 525758. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 09 ago 1989 Consegnato il 16 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0