PEOPLES PHONE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PEOPLES PHONE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02262870 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PEOPLES PHONE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PEOPLES PHONE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PEOPLES PHONE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE PEOPLES PHONE COMPANY PLC | 28 feb 1994 | 28 feb 1994 |
| CELLULAR COMMUNICATIONS CORPORATION PLC | 27 mag 1988 | 27 mag 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PEOPLES PHONE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per PEOPLES PHONE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 19 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 16 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 15 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 13 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 17 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 14 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 07 mar 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN | 1 pagine | AD04 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di PEOPLES PHONE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| EVANS, David Nigel | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||||||
| DAWE-LANE, Patrick John Beachim | Segretario | Marsh Lane Rowde SN10 1RE Devizes Upper Foxhangers Farm Wiltshire England | Other | 130771170001 | ||||||||||
| EMETULU, Lola | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 88619360002 | ||||||||||
| HOWIE, Philip Robert Sutherland | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||||||
| PARRISH, Keith John | Segretario | 33 Reads Field Four Marks GU34 5XA Alton Hampshire | British | 65075990001 | ||||||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Segretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||||||
| BAMFORD, Peter Richard | Amministratore | Lantern House 4a Queens Gate Place SW7 5NT London | British | 54076100002 | ||||||||||
| BEST, Pauline Ann | Amministratore | Honeysuckle Cottage Sutton Lane Sutton OX29 5RU Witney Oxfordshire | British | 68015830001 | ||||||||||
| BISWAS, Sumit Kumar | Amministratore | 21 South Street OX2 0BE Oxford Oxfordshire | British | 63870460001 | ||||||||||
| BREWER, Stephen | Amministratore | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Amministratore | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||||||
| CHESWORTH, Paul | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||||||
| EDWARDS, Peter David | Amministratore | Hockets Oriental Road SL5 7AZ Sunninghill Berkshire | British | 1908570001 | ||||||||||
| EVANS, Mark | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||||||
| FREEMAN, William Ian Bede | Amministratore | Herons Cottage Ferry Lane, Medmenham SL7 2EZ Marlow Buckinghamshire | England | British | 64442870001 | |||||||||
| GARDNER, Malcolm William | Amministratore | Dryson House Edge Business Centre Humber Road NW2 6EW London | British | 48770690002 | ||||||||||
| GENT, Christopher Charles | Amministratore | Crowshott Highclere RG20 9RY Newbury Berkshire | British | 50867930001 | ||||||||||
| GIBBINS, Michael Edward Stanley | Amministratore | 36 Hurlingham Square Peterborough Road SW6 3DZ London | British | 39579200001 | ||||||||||
| GRAY, Ian | Amministratore | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | 50246030004 | |||||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Amministratore | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||||||
| HANFORD, Raymond Clifford | Amministratore | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 45868080001 | |||||||||
| HANFORD, Raymond Clifford | Amministratore | Romney Cottage Park Horsley East Horsley KT24 5RZ Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | 45868080001 | |||||||||
| HEXT, Jane Helen | Amministratore | 2 Saint Katherines Winterbourne Bassett SN4 9QG Swindon Wiltshire | England | British | 152305810001 | |||||||||
| HOLMES, Stephen Edward | Amministratore | Parsonage Farm Stanbridge Earls SO51 0HE Romsey Hampshire | England | British | 6218790003 | |||||||||
| JONES, David Leslie | Amministratore | Three Oak Barn RH14 0PY Plaistow West Sussex | British | 83517310001 | ||||||||||
| KEAYS, Helen Margaret | Amministratore | Clematis Cottage Old Warwick Road Rowington CV35 7AA Warwick Warwickshire | British | 55393460002 | ||||||||||
| KEY, Matthew David | Amministratore | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||||||
| LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||||||
| LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||||||
| MELHUISH-HANCOCK, Douglas Charles | Amministratore | 22 Nightingale House E1W 1UA London | United Kingdom | British | 6218780001 | |||||||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PEOPLES PHONE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Retail (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PEOPLES PHONE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of rental deposit | Creato il 13 mag 1998 Consegnato il 20 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 9TH december 1992 | |
Brevi particolari The sum of £32,500 together with all other sums to be paid into the account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 ott 1995 Consegnato il 18 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture and under the facility letter and/or in each case any deed or document supplemental thereto | |
Brevi particolari Units 2,3 & 4 edge business centre humber road london NW2 6EF t/nos.NGL643301 NGL643288 and NGL668789. Peoples phone house edgware road london NW2 being the f/h property formerly k/a carlton forge garage edgware road cricklewood t/no. NGL525914. Victory park edgware road london being the f/h property on the north east side of edgware road cricklewood t/nos.NGL638762 NGL697023. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 08 ago 1995 Consegnato il 09 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from the company to the chargees pursuant to the terms of a lease dated 22/9/86 | |
Brevi particolari The amount from time to time standing to the credit of an interest earning deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 23 mag 1995 Consegnato il 09 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 6TH january 1978 | |
Brevi particolari All amounts which are now or which may from time to time be standing to the credit of the account number 10733040 with barclays bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 07 apr 1995 Consegnato il 13 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15 april 1985 and this deed | |
Brevi particolari £17,250 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 27 gen 1995 Consegnato il 07 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £13,500 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari £13,500 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 17 gen 1995 Consegnato il 21 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £17,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari £17,000 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 11 gen 1995 Consegnato il 13 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The company's obligations to the chargee under the terms of the lease | |
Brevi particolari The amount of the deposit being £11,875.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 dic 1994 Consegnato il 04 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 22 dic 1994 Consegnato il 24 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the services provider agreements (as defined) or on any account whatsoever | |
Brevi particolari The interest of the company in it's customers from time to time and all goodwill associated with the vodafon network and benefit of the service provider agreements see form 395 for full details of all charged assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Agreement and charge | Creato il 22 dic 1994 Consegnato il 23 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility documents (as defined) | |
Brevi particolari By way of equitable assignment all it's right title interest and benefit in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 03 ott 1994 Consegnato il 04 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations of the purchaser to the vendor under the terms of the lease | |
Brevi particolari The amount of the deposit being £3,125.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 11 ago 1994 Consegnato il 19 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The company's obligations to the chargee under the terms of the leases | |
Brevi particolari The amount of deposit being 411.542.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 11 ago 1994 Consegnato il 19 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The company's obligations to the chargee under the terms of the leases | |
Brevi particolari The amount of deposit being £115,656.oo together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument | Creato il 14 gen 1994 Consegnato il 27 gen 1994 Data dello strumento di garanzia 14 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | ||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of deposit | Creato il 28 lug 1989 Consegnato il 01 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 28.7.89 | |
Brevi particolari The companys' interest in the deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 giu 1989 Consegnato il 14 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h property k/a unit 1 the edge business centre, humber rd london NW2 including all fixed & moveable plant & machinery & fixture furniture implements & utensils & the goodwill of the business of a licensed hotelier & the benefit of all justices' excise or other licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 nov 1988 Consegnato il 21 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan stock as defined in the deed. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 08 nov 1988 Consegnato il 10 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0