PEOPLES PHONE LIMITED

PEOPLES PHONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEOPLES PHONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02262870
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEOPLES PHONE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PEOPLES PHONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEOPLES PHONE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE PEOPLES PHONE COMPANY PLC28 feb 199428 feb 1994
    CELLULAR COMMUNICATIONS CORPORATION PLC27 mag 198827 mag 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEOPLES PHONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PEOPLES PHONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 07 mar 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium a/c 22/02/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN

    1 pagineAD04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2016

    Stato del capitale al 14 mar 2016

    • Capitale: GBP 437,028
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PEOPLES PHONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2357692
    75473330004
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    DAWE-LANE, Patrick John Beachim
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Segretario
    Marsh Lane
    Rowde
    SN10 1RE Devizes
    Upper Foxhangers Farm
    Wiltshire
    England
    Other130771170001
    EMETULU, Lola
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British88619360002
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    PARRISH, Keith John
    33 Reads Field
    Four Marks
    GU34 5XA Alton
    Hampshire
    Segretario
    33 Reads Field
    Four Marks
    GU34 5XA Alton
    Hampshire
    British65075990001
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BAMFORD, Peter Richard
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    Amministratore
    Lantern House
    4a Queens Gate Place
    SW7 5NT London
    British54076100002
    BEST, Pauline Ann
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    Amministratore
    Honeysuckle Cottage
    Sutton Lane Sutton
    OX29 5RU Witney
    Oxfordshire
    British68015830001
    BISWAS, Sumit Kumar
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    21 South Street
    OX2 0BE Oxford
    Oxfordshire
    British63870460001
    BREWER, Stephen
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 10 Rushworth House
    Enborne Lodge Lane
    RG14 6RH Newbury
    Berkshire
    British79186090002
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    EDWARDS, Peter David
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Hockets
    Oriental Road
    SL5 7AZ Sunninghill
    Berkshire
    British1908570001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    FREEMAN, William Ian Bede
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Herons Cottage
    Ferry Lane, Medmenham
    SL7 2EZ Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish64442870001
    GARDNER, Malcolm William
    Dryson House Edge Business Centre
    Humber Road
    NW2 6EW London
    Amministratore
    Dryson House Edge Business Centre
    Humber Road
    NW2 6EW London
    British48770690002
    GENT, Christopher Charles
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Crowshott
    Highclere
    RG20 9RY Newbury
    Berkshire
    British50867930001
    GIBBINS, Michael Edward Stanley
    36 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    Amministratore
    36 Hurlingham Square
    Peterborough Road
    SW6 3DZ London
    British39579200001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Amministratore
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HALFORD, Andrew Nigel
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Oxdrove House
    Burghclere
    RG20 9HJ Newbury
    Berkshire
    British33951180005
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish45868080001
    HANFORD, Raymond Clifford
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Romney Cottage Park Horsley
    East Horsley
    KT24 5RZ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish45868080001
    HEXT, Jane Helen
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Saint Katherines
    Winterbourne Bassett
    SN4 9QG Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish152305810001
    HOLMES, Stephen Edward
    Parsonage Farm
    Stanbridge Earls
    SO51 0HE Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    Parsonage Farm
    Stanbridge Earls
    SO51 0HE Romsey
    Hampshire
    EnglandBritish6218790003
    JONES, David Leslie
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    Amministratore
    Three Oak Barn
    RH14 0PY Plaistow
    West Sussex
    British83517310001
    KEAYS, Helen Margaret
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Clematis Cottage
    Old Warwick Road Rowington
    CV35 7AA Warwick
    Warwickshire
    British55393460002
    KEY, Matthew David
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Yardley School Lane
    Seer Green
    HP9 2QJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62981720001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Amministratore
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MELHUISH-HANCOCK, Douglas Charles
    22 Nightingale House
    E1W 1UA London
    Amministratore
    22 Nightingale House
    E1W 1UA London
    United KingdomBritish6218780001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PEOPLES PHONE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3381659
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PEOPLES PHONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of rental deposit
    Creato il 13 mag 1998
    Consegnato il 20 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease dated 9TH december 1992
    Brevi particolari
    The sum of £32,500 together with all other sums to be paid into the account.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 ott 1995
    Consegnato il 18 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture and under the facility letter and/or in each case any deed or document supplemental thereto
    Brevi particolari
    Units 2,3 & 4 edge business centre humber road london NW2 6EF t/nos.NGL643301 NGL643288 and NGL668789. Peoples phone house edgware road london NW2 being the f/h property formerly k/a carlton forge garage edgware road cricklewood t/no. NGL525914. Victory park edgware road london being the f/h property on the north east side of edgware road cricklewood t/nos.NGL638762 NGL697023. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 ago 1995
    Consegnato il 09 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company to the chargees pursuant to the terms of a lease dated 22/9/86
    Brevi particolari
    The amount from time to time standing to the credit of an interest earning deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter Francis Ringrose David Michael Flather and Alexander Humphrey Fletcher
    Transazioni
    • 09 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 6TH january 1978
    Brevi particolari
    All amounts which are now or which may from time to time be standing to the credit of the account number 10733040 with barclays bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Pentagon Developments (Chatham) Limited
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 apr 1995
    Consegnato il 13 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease dated 15 april 1985 and this deed
    Brevi particolari
    £17,250 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Dollond & Aitchison Group (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 13 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 gen 1995
    Consegnato il 07 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £13,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £13,500 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Dollond & Aitchison Group (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 07 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 gen 1995
    Consegnato il 21 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £17,000 in a separate designated deposit account in the name of dibb lupton broomhead solicitors to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Dollond & Aitchison Group (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 21 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 gen 1995
    Consegnato il 13 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The company's obligations to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The amount of the deposit being £11,875.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Signet Group PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 dic 1994
    Consegnato il 04 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hawthorn Leslie Group Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge
    Creato il 22 dic 1994
    Consegnato il 24 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the services provider agreements (as defined) or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The interest of the company in it's customers from time to time and all goodwill associated with the vodafon network and benefit of the service provider agreements see form 395 for full details of all charged assets.
    Persone aventi diritto
    • Vodafone Limited
    Transazioni
    • 24 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement and charge
    Creato il 22 dic 1994
    Consegnato il 23 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    By way of equitable assignment all it's right title interest and benefit in and to the receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 ott 1994
    Consegnato il 04 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the purchaser to the vendor under the terms of the lease
    Brevi particolari
    The amount of the deposit being £3,125.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Signet Group PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 19 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The company's obligations to the chargee under the terms of the leases
    Brevi particolari
    The amount of deposit being 411.542.00 together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Signet Group PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 11 ago 1994
    Consegnato il 19 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The company's obligations to the chargee under the terms of the leases
    Brevi particolari
    The amount of deposit being £115,656.oo together with any additions thereto pursuant to the provisions of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Signet Group PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Instrument
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 27 gen 1994
    Data dello strumento di garanzia 14 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Group PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1994Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 29 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of deposit
    Creato il 28 lug 1989
    Consegnato il 01 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 28.7.89
    Brevi particolari
    The companys' interest in the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • P & R Properties Limited
    Transazioni
    • 01 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 giu 1989
    Consegnato il 14 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a unit 1 the edge business centre, humber rd london NW2 including all fixed & moveable plant & machinery & fixture furniture implements & utensils & the goodwill of the business of a licensed hotelier & the benefit of all justices' excise or other licences.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 14 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 nov 1988
    Consegnato il 21 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan stock as defined in the deed.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ocean Venture Limited
    Transazioni
    • 21 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 nov 1988
    Consegnato il 10 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0