TRISTAR CARS LIMITED

TRISTAR CARS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRISTAR CARS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02263554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRISTAR CARS LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri via terra (49390) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova TRISTAR CARS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRISTAR CARS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DATETOUR LIMITED01 giu 198801 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRISTAR CARS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TRISTAR CARS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Soddisfazione dell'onere 022635540017 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 giu 2017

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 mag 2016

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 022635540017, creata il 25 ago 2016

    50 pagineMR01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Mr Andrew Ross Hohne come amministratore in data 28 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Kenneth Boland come amministratore in data 28 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Dean Peter De Beer come amministratore in data 28 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Ross Hohne come segretario in data 28 giu 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andrew Kenneth Boland come amministratore in data 28 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Dean Peter De Beer come amministratore in data 28 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Richard Withers Green come amministratore in data 28 giu 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Ross Hohne come amministratore in data 28 giu 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mag 2015

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2015

    Stato del capitale al 06 ott 2015

    • Capitale: GBP 338,543
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Dean Peter De Beer il 01 set 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di TRISTAR CARS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DE BEER, Dean Peter
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Amministratore
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritishManaging Director55606080007
    HOHNE, Andrew Ross
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Amministratore
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritishDirector63390230005
    DE BEER, Dean Peter
    64 Perrers Road
    Hammersmith
    W6 0EZ London
    Segretario
    64 Perrers Road
    Hammersmith
    W6 0EZ London
    BritishAccountant55606080003
    HOHNE, Andrew Ross
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Segretario
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    BritishFinance Director63390230005
    PIGGOTT, Phillip John Christopher
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    Segretario
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    British18305220003
    ROSS, David Peter John
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    Segretario
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    BritishDirector43841990001
    BOLAND, Andrew Kenneth
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Amministratore
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    United KingdomBritishChief Executive Officer71264540006
    CLARINGBOLD, Douglas Bryan
    96 Staines Road
    TW19 5AG Wraysbury
    Middlesex
    Amministratore
    96 Staines Road
    TW19 5AG Wraysbury
    Middlesex
    EnglandBritishOperations Director199706860001
    DALE, James Hall
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Amministratore
    Bradda Brae
    Bradda East
    IM9 6QB Port Erin
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Accountant84675480001
    DE BEER, Dean Peter
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Amministratore
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritishManaging Director55606080007
    DUNSTONE, Charles William
    84 Campden Street
    W8 7EN London
    Amministratore
    84 Campden Street
    W8 7EN London
    BritishDirector43842070001
    HOHNE, Andrew Ross
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Amministratore
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritishFinance Director63390230005
    KEENLYSIDE, Philip Aiden
    11 The Riverside
    Graburn Way
    KT8 9BF East Moseley
    Surrey
    Amministratore
    11 The Riverside
    Graburn Way
    KT8 9BF East Moseley
    Surrey
    BritishAdministrtive Directoror13017990003
    PIGGOTT, Phillip John Christopher
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    Ashcroft Snow Hill
    Copthorne
    RH10 3EY Crawley
    West Sussex
    BritishAdministrative Director18305220003
    ROSS, David Peter John
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    Amministratore
    Flat 4 4 Roland Gardens
    SW7 3PM London
    BritishDirector43841990001
    WITHERS GREEN, Anthony Richard
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    Amministratore
    Unit 1 Horton Road
    West Drayton
    UB7 8BQ Middlesex
    EnglandBritishSales And Marketing Director83786360002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRISTAR CARS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bodycove Ltd
    Horton Road
    UB7 8BQ West Drayton
    Unit 1
    England
    01 ott 2016
    Horton Road
    UB7 8BQ West Drayton
    Unit 1
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies England And Wales
    Numero di registrazione03292923
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TRISTAR CARS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 ago 2016
    Consegnato il 05 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The real property and the intellectual property specified in the instrument including the leasehold at 2003-2004 (postal 1A, 1B, 1C and 2), horton road, west drayton, middlesex, UB7 8BQ (title number: AGL193707) and the intellectual property listed in schedule 7 to the instrument. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 05 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 feb 2012
    Consegnato il 09 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of confirmation and variation
    Creato il 03 feb 2012
    Consegnato il 09 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 09 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 feb 2012
    Consegnato il 03 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC as Security Trustee (Security Holder) for Each Group Member
    Transazioni
    • 03 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 22 apr 2010
    Consegnato il 29 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MG01 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re tristar cars limited business premium account account number 13321371.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2008
    Consegnato il 12 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 gen 2008
    Consegnato il 16 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery (for details of properties please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 16 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 gen 2008
    Consegnato il 12 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 dic 2004
    Consegnato il 15 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2004
    Consegnato il 18 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All asset debenture
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 02 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 14 ago 2002
    Consegnato il 20 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture deed
    Creato il 14 ago 2002
    Consegnato il 15 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 15 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 28 ago 1992
    Consegnato il 15 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H bungalow and blck corner garage t/nos sy 210971 and wsx 11313 together with all buildings and fixtures thereon assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 feb 1991
    Consegnato il 13 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at buildings at west side of rutherford way, crawley, west sussex title no. Wsx 90343. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 01 dic 1988
    Consegnato il 05 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixture. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 nov 1988
    Consegnato il 23 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts. Floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (including those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 1988Registrazione di un'ipoteca

    TRISTAR CARS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 nov 2018Data di scioglimento
    30 giu 2017Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Barry John Stewart
    2nd Floor Suite 148, Central Chambers
    11 Bothwell Street
    G2 6LY Glasgow
    Praticante
    2nd Floor Suite 148, Central Chambers
    11 Bothwell Street
    G2 6LY Glasgow

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0