MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED

MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMYTRE PROPERTY TRUST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02265367
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Upper Berkeley Street
    London
    W1H 7PE
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RAPID 6224 LIMITED07 giu 198807 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    pagineGAZ1(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 01 ott 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Jeremy De Barr come segretario in data 23 giu 2017

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Neil Steinberg il 02 mag 2017

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 lug 2016

    Stato del capitale al 06 lug 2016

    • Capitale: GBP 5,011,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Ross Collins il 01 set 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2015

    Stato del capitale al 22 lug 2015

    • Capitale: GBP 5,011,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLE, Terence Shelby
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    Amministratore
    Phillimore Gardens
    W8 7QE London
    24
    United KingdomBritish71810060003
    COLLINS, Steven Ross
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    Amministratore
    Bulstrode Street
    W1U 2JH London
    17
    England
    EnglandBritish7128850005
    STEINBERG, Mark Neil
    Cadogan Square
    SW1X 0HU London
    Flat 2, 25
    England
    Amministratore
    Cadogan Square
    SW1X 0HU London
    Flat 2, 25
    England
    United KingdomBritish59275730001
    DE BARR, Richard Jeremy
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    Segretario
    38 Tring Avenue
    W5 3QB London
    British43885410001
    HOWLAND, Nora
    64 Albion Street
    CT10 1NF Broadstairs
    Kent
    Segretario
    64 Albion Street
    CT10 1NF Broadstairs
    Kent
    British7553810001
    MELLISH, Richard Paul
    18 Graham Avenue
    W13 9TQ London
    Segretario
    18 Graham Avenue
    W13 9TQ London
    British121886140001
    BRILLING, Michael John
    24 Lexham House
    53 Lexham Gardens
    W8 5JT London
    Amministratore
    24 Lexham House
    53 Lexham Gardens
    W8 5JT London
    EnglandBritish7553820001
    JAYE, Andrew Ian
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    Weatheroak
    The Common
    HA7 3HP Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish10174290002
    KLEEMAN, David George
    141 Hamilton Terrace
    NW8 9QS London
    Amministratore
    141 Hamilton Terrace
    NW8 9QS London
    British33770960001
    LEAVER, Brian Ivan
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    The Garden House
    72 Paines Lane
    HA5 3BL Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish13082210001
    NADLER, Robert Arthur
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    Amministratore
    123 Old Church Street
    SW3 6EA London
    United KingdomBritish33752790002
    ROSS, Nigel Keith
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    Amministratore
    60 Cumberland Terrace
    NW1 4HJ London
    United KingdomBritish47878830001
    RUBENS, Kenneth David
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    Amministratore
    61 Springfield Road
    St Johns Wood
    NW8 0QJ London
    United KingdomBritish35531750001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Innerwyke Investments Limited
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    06 apr 2016
    Upper Berkeley Street
    W1H 7PE London
    10
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MYTRE PROPERTY TRUST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 mar 2012
    Consegnato il 11 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H 13-23 military road chatham t/nos K560673 and K700134. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 11 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for and Onbehalf of the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 07 lug 1995
    Consegnato il 19 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or seymour development limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter dated 6TH july 1995 and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge
    Brevi particolari
    Freehold land and building known as farringdon point, 29-35(odd numbers) farringdon road, london EC1 title number LN229578 and the proceeds of sale thereof a floating charge over all moveable plant, machienery, implements, building materials of all kinds, utensils, furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 19 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    142/148 (even) high street, new malden. T/n sgl 523804. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    104, wigmore street, london W1. T/n ngl 23361. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    190/196, walton street, chelsea, london, SW3 t/n 441548.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 09 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    122/124, malden road, and 120/120B malden road, new malden, kingston upon thames t/n sy 21760.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 12 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1989
    Consegnato il 14 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    142/148 (even) high street new malden t/no. Sgl 523804 fixed charge only.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1989
    Consegnato il 14 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    190/196 walton street chelsea london SW3 t/no. 441548 fixed charge only.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1989
    Consegnato il 14 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    104 wigmore street london SW3 t/no. Ngl 23361 fixed charge only.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1989
    Consegnato il 14 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    122/124 maldon road and 120A/120B maldon road new malden kingston upon thames t/no. SY21760 fixed charge only.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0