SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED

SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02265468
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIRMINGHAM SERVICETEAM LIMITED27 mar 200127 mar 2001
    TRANPLAN LIMITED20 mag 199820 mag 1998
    D.R. GODFREY LIMITED08 giu 198808 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 gen 2017

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da 210 Pentonville Road London N1 9JY a 6 Snow Hill London EC1A 2AY in data 19 gen 2017

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2016

    Stato del capitale al 08 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2015

    Stato del capitale al 28 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Nomina di Miss Elaine Margaret Aitken come segretario in data 12 ago 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Robert Charles Hunt come segretario in data 12 ago 2014

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2014

    Stato del capitale al 28 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr Robert Charles Hunt come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 8Th Floor 210 Pentonville Road London N1 9JY England* in data 30 apr 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Richard Berry come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Robert Charles Hunt come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Levett come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AITKEN, Elaine Margaret
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    England
    Segretario
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    England
    190255230001
    GERRARD, David Andrew
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    England
    Amministratore
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    England
    United KingdomBritish136575180001
    HUNT, Robert Charles
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    England
    Amministratore
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    England
    United KingdomBritish87174080001
    BERRY, Richard Douglas
    210 Pentonville Road
    N1 9JY London
    8th Floor
    England
    Segretario
    210 Pentonville Road
    N1 9JY London
    8th Floor
    England
    Australian134071050001
    BOHAN, Adrienne
    114 Crescent Road
    EN4 9RJ New Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    114 Crescent Road
    EN4 9RJ New Barnet
    Hertfordshire
    Irish56124860001
    BOULT, Michael Gordon
    318 Fir Tree Road
    KT17 3NW Epsom Downs
    Surrey
    Segretario
    318 Fir Tree Road
    KT17 3NW Epsom Downs
    Surrey
    British45388810001
    CANE, Micheal Geoffrey
    Falstaff Close
    Walmley
    B76 1YG Sutton Coldfield
    31
    Segretario
    Falstaff Close
    Walmley
    B76 1YG Sutton Coldfield
    31
    British132670220001
    CHAMBERLAIN, Ian Philip
    10 Orwell Road
    Barrington
    CB2 5SE Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    10 Orwell Road
    Barrington
    CB2 5SE Cambridge
    Cambridgeshire
    British28873120001
    HUNT, Robert Charles
    Pentonville Road
    N1 9JY London
    210
    England
    Segretario
    Pentonville Road
    N1 9JY London
    210
    England
    165567060001
    HUNT, Robert Charles
    The Chestnuts
    The Ley Box
    SN13 8JX Corsham
    Wiltshire
    Segretario
    The Chestnuts
    The Ley Box
    SN13 8JX Corsham
    Wiltshire
    British87174080001
    MURPHY, Francis Joseph
    Home Farm
    North End Lane Fulbeck
    NG32 3JR Grantham
    Lincolnshire
    Segretario
    Home Farm
    North End Lane Fulbeck
    NG32 3JR Grantham
    Lincolnshire
    British32866430001
    PORRITT, Kerry Anne Abigail
    Brushwood House
    22 Clarence Road
    WR14 3EH Great Malvern
    Worcestershire
    Segretario
    Brushwood House
    22 Clarence Road
    WR14 3EH Great Malvern
    Worcestershire
    British166987180001
    RAINE, Richard Denby
    19 Madrid Road
    SW13 9PF London
    Segretario
    19 Madrid Road
    SW13 9PF London
    British50519950002
    THOMPSON, Patrick Guy Netterville
    30 Shooters Hill Road
    SE3 7BD London
    Segretario
    30 Shooters Hill Road
    SE3 7BD London
    British66442860001
    WALKER, Philip Francis John
    9 Gilmore Road
    SE13 5AD London
    Segretario
    9 Gilmore Road
    SE13 5AD London
    British45389220001
    BOULT, Michael Gordon
    68 Hillside
    SM7 1HF Banstead
    Surrey
    Amministratore
    68 Hillside
    SM7 1HF Banstead
    Surrey
    British45388810002
    CRESSWELL, Richard Tom
    20 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    20 New Road
    AL6 0AG Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritish21952540002
    DE SAINT QUENTIN, Axel
    5l Portman Mansions
    Chiltern Street
    W1M 1PU London
    Amministratore
    5l Portman Mansions
    Chiltern Street
    W1M 1PU London
    French73659370001
    DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, Cyrille
    89 Kensington Court Mansions
    W8 5DU London
    Amministratore
    89 Kensington Court Mansions
    W8 5DU London
    French110242530002
    GREENHALGH, Gary
    Washdyke Farm
    Lincoln Road
    NG32 3HY Fulbeck
    Lincolnshire
    Amministratore
    Washdyke Farm
    Lincoln Road
    NG32 3HY Fulbeck
    Lincolnshire
    United KingdomBritish1192810001
    HODGSON, Peter Gerald Pearson
    Arlington
    Ashstead Park
    KT21 1EG Ashstead
    Surrey
    Amministratore
    Arlington
    Ashstead Park
    KT21 1EG Ashstead
    Surrey
    EnglandBritish45385340001
    HUXLEY, Stephen George
    Manor Farm House 33 High Street
    Ketton
    PE9 3TA Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    Manor Farm House 33 High Street
    Ketton
    PE9 3TA Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritish96882500001
    KILONBACK, David John
    12 Rivermead
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    12 Rivermead
    KT8 9AZ East Molesey
    Surrey
    British63153610001
    LEVETT, Paul
    210 Pentonville Road
    N1 9JY London
    8th Floor
    England
    Amministratore
    210 Pentonville Road
    N1 9JY London
    8th Floor
    England
    EnglandBritish44441110002
    MALIK, Mushtaq Hussain
    2 Quentin Road
    Blackheath
    SE13 5DQ London
    Amministratore
    2 Quentin Road
    Blackheath
    SE13 5DQ London
    British43136860001
    MALLETT, Gary James
    26 Chancellor Avenue
    CM2 6WS Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    26 Chancellor Avenue
    CM2 6WS Chelmsford
    Essex
    Australian87652700001
    MCGRATH, Stephen John
    Brookfield
    Highford Lane
    NE46 2DP Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Brookfield
    Highford Lane
    NE46 2DP Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish73426550001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MITCHELL, Brenden
    Tudor Cottage
    Green Road Rickling Green
    CB11 3YD Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Tudor Cottage
    Green Road Rickling Green
    CB11 3YD Saffron Walden
    Essex
    Australian100757060001
    NOLAN, Paul Laurence
    18 Goldrings Road
    KT22 0QR Oxshott
    Bridgend House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    18 Goldrings Road
    KT22 0QR Oxshott
    Bridgend House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish139216460001
    RAINE, Richard Denby
    19 Madrid Road
    SW13 9PF London
    Amministratore
    19 Madrid Road
    SW13 9PF London
    United KingdomBritish50519950002
    REED, Michael Geoffrey
    The Green
    Barrow
    IP29 5AA Bury St. Edmunds
    Ormesby Cottage
    Suffolk
    Amministratore
    The Green
    Barrow
    IP29 5AA Bury St. Edmunds
    Ormesby Cottage
    Suffolk
    EnglandBritish136222240001
    REVELL, Anthony William
    26 Ryland Road
    Welton
    LN2 3LU Lincoln
    Amministratore
    26 Ryland Road
    Welton
    LN2 3LU Lincoln
    British980590001
    RUDD, Jeremy George Winterton
    Brabant, Gibbs Lane
    Offenham
    WR11 8RR Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Brabant, Gibbs Lane
    Offenham
    WR11 8RR Evesham
    Worcestershire
    British79668780001
    STEWARD, Michael
    Old Farm
    Lower Potton Road Croydon
    SG8 0HE Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Farm
    Lower Potton Road Croydon
    SG8 0HE Royston
    Hertfordshire
    British16406470001

    SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 gen 2000
    Consegnato il 03 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 lug 1997
    Consegnato il 28 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the investment agreement and/or the deed of guarantee and/or any agreement or other documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC for Itself and as Security Trustee for the Investors
    Transazioni
    • 28 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 feb 1997
    Consegnato il 11 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 3RD february 1997 and the debenture (as defined therein)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Plcacting for Itself and as Trustee on Behalf of the Investors Under the Investment Agreement ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 11 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 1996
    Consegnato il 10 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a deed of guarantee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Plcfor Itself and as Trustee on Behalf of the Investors Under the Investment Agreement (As Defined)
    Transazioni
    • 10 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined therein) on any account whatsoever under or in connection with any of the financing documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas as Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 dic 1988
    Consegnato il 05 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including heritable property & assets in scotland lease of first floor offices at 14A hill street saffron walden. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SERVICETEAM BIRMINGHAM LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 gen 2017Inizio della liquidazione
    11 ott 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael David Rollings
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Steven Edward Butt
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London
    Praticante
    Rollings Butt Llp 6 Snow Hill
    EC1A 2AY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0