VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02269223 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Battleship Building 179 Harrow Road W2 6NB London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CURRENT SPONGE PRODUCTIONS LIMITED | 11 giu 2012 | 11 giu 2012 |
| SUN DOG PICTURES LIMITED | 29 feb 2012 | 29 feb 2012 |
| SENSE NATION LIMITED | 21 feb 2012 | 21 feb 2012 |
| VANSON HOTELS LIMITED | 07 nov 1988 | 07 nov 1988 |
| SQUAREFIN 116 LIMITED | 20 giu 1988 | 20 giu 1988 |
Quali sono le ultime deposizioni per VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The School House 50 Brook Green London W6 7RR in data 04 apr 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert George Mccormack il 02 apr 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Alexander Ralph Gerrard il 02 apr 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Alexander Ralph Gerrard il 17 dic 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert George Mccormack come amministratore in data 06 nov 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tilesh Chimanbhai Patel come amministratore in data 06 nov 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed current sponge productions LIMITED\certificate issued on 26/09/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed sun dog pictures LIMITED\certificate issued on 11/06/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed sense nation LIMITED\certificate issued on 29/02/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed vanson hotels LIMITED\certificate issued on 21/02/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Tilesh Chimanbhai Patel come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Cohen come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Caroline Ann Drake il 31 gen 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Mark Cohen il 31 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gordon Mccallum come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jane Phillips come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Jonathan Mark Cohen come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAKE, Caroline Ann | Segretario | 179 Harrow Road W2 6NB London The Battleship Building United Kingdom | Other | 70982540001 | ||||||
| GERRARD, Barry Alexander Ralph | Amministratore | 179 Harrow Road W2 6NB London The Battleship Building United Kingdom | United Kingdom | British | 188290036 | |||||
| MCCORMACK, Robert George | Amministratore | 179 Harrow Road W2 6NB London The Battleship Building United Kingdom | United Kingdom | British | 173443610001 | |||||
| BAYLISS, Joshua | Segretario | 15 Hopefield Avenue NW6 6LJ London | British | 114409340001 | ||||||
| COOK, Janice Susan | Segretario | 33 Stanley Road South Harrow HA2 8AY London | British | 58934320001 | ||||||
| GERRARD, Barry Alexander Ralph | Segretario | 17 Mowbray Close MK43 8LF Bromham Bedfordshire | British | 188290001 | ||||||
| GRAM, Peter Gerardus | Segretario | 9 Lambyn Croft Langshott RH6 9XU Horley Surrey | British | 67245530001 | ||||||
| LEGGE, Diana Patricia | Segretario | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||
| POTTS, Derek | Segretario | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | British | 52485510001 | ||||||
| ABBOTT, Trevor Michael | Amministratore | Blendons Highcotts Lane West Clandon GU4 7XA Guildford Surrey | British | 35278820001 | ||||||
| BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir | Amministratore | 9 Holland Park W11 3TH London | British | 39498750002 | ||||||
| BURROUGHS, Ian Steven | Amministratore | 26 Mount Close RH10 7EF Crawley West Sussex | United Kingdom | British | 105323210001 | |||||
| COHEN, Jonathan Mark | Amministratore | 50 Brook Green W6 7RR London The School House | England | British | 131608080001 | |||||
| GRAM, Peter Gerardus | Amministratore | 9 Lambyn Croft Langshott RH6 9XU Horley Surrey | British | 67245530001 | ||||||
| HALL, Susannah Mary Louise | Amministratore | 76 Sutton Court Chiswick W4 3JF London | British | 75930520004 | ||||||
| HILL, Mark Frederick David | Amministratore | 1 Birkbeck Road Ealing W5 4ES London | British | 102025040001 | ||||||
| LEGGE, Diana Patricia | Amministratore | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||
| MCCALLUM, Gordon Douglas | Amministratore | 50 Brook Green Hammersmith W6 7RR London The School House United Kingdom | United Kingdom | British | 55294030006 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas Matthew | Amministratore | 23 The Crescent SW13 0NN London | British | 70496800002 | ||||||
| PATEL, Tilesh Chimanbhai | Amministratore | 50 Brook Green W6 7RR London The School House United Kingdom | England | British | 160075020001 | |||||
| PHILLIPS, Jane Elizabeth Margaret | Amministratore | 10 Hornminster Glen RM11 3XL Hornchurch Essex | England | British | 85707450003 | |||||
| VICCARY, Arthur William George | Amministratore | Medomsley Byfleet Road KT11 1EA Cobham Surrey | British | 2899730001 | ||||||
| WALKER, Arthur Frank | Amministratore | Kershaw Northern Heights SL8 5LE Bourne End Buckinghamshire | British | 2899740001 |
VIRGIN TELEVISION INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 19 ott 1989 Consegnato il 01 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent & trustee for the banks as defined) under the terms of a loan agreement of even date and/or this charge | |
Brevi particolari 58, 60, 62 & 64 english street carlisle cumbria t/no cu 49167 & all buildings & fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 gen 1989 Consegnato il 18 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the banks) under the terms of a loan agreement dated 16/12/88 | |
Brevi particolari 58, 60, 62 & 64 english street, carlisle, cumbria. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0