GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED

GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02269409
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    164 Barkby Road
    Leicester
    LE4 9LF
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEICESTER PRINTERS LIMITED20 giu 198820 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Cessazione della carica di Jacqueline Ann Seabrook come segretario in data 31 gen 2022

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul John Heath come amministratore in data 08 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 dic 2015

    Stato del capitale al 03 dic 2015

    • Capitale: GBP 176,990
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 nov 2014

    Stato del capitale al 24 nov 2014

    • Capitale: GBP 176,990
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 dic 2013

    Stato del capitale al 02 dic 2013

    • Capitale: GBP 176,990
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    YELL, John Anthony
    2 Grange Park
    Thurnby
    LE7 9QQ Leicester
    Amministratore
    2 Grange Park
    Thurnby
    LE7 9QQ Leicester
    EnglandBritishDirector6136950002
    BRUNDELL, Paul James
    10 Main Street
    Burrough On The Hill
    LE14 2JQ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Segretario
    10 Main Street
    Burrough On The Hill
    LE14 2JQ Melton Mowbray
    Leicestershire
    British39106260003
    CARTER, Andrew
    Willowbank 16 South Street
    Isham
    NN14 1HP Kettering
    Northamptonshire
    Segretario
    Willowbank 16 South Street
    Isham
    NN14 1HP Kettering
    Northamptonshire
    British6136900002
    CARTER, Andrew
    24 Fineshade Close
    Barton Seagrave
    NN15 6SL Kettering
    Northamptonshire
    Segretario
    24 Fineshade Close
    Barton Seagrave
    NN15 6SL Kettering
    Northamptonshire
    British6136900001
    SEABROOK, Jacqueline Ann
    4 Tokyes Close
    Belton In Rutland
    LE15 9JP Oakham
    Thornhill
    Rutland
    United Kingdom
    Segretario
    4 Tokyes Close
    Belton In Rutland
    LE15 9JP Oakham
    Thornhill
    Rutland
    United Kingdom
    British114015090001
    SEABROOK, Jacqueline Ann
    Paddock Corner
    Main Street
    LE8 0PG Shangton
    Leicestershire
    Segretario
    Paddock Corner
    Main Street
    LE8 0PG Shangton
    Leicestershire
    British114015090001
    SPENCER, Christopher William
    2 The Pinfold
    Markfield
    LE67 9QU Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    2 The Pinfold
    Markfield
    LE67 9QU Leicester
    Leicestershire
    British102002410001
    FEWKES, Keith Alan
    One Wentworth Green
    Kirby Muxloe
    LE9 2EQ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    One Wentworth Green
    Kirby Muxloe
    LE9 2EQ Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector22514720001
    GRINYER, Phillip William
    19 Whiteoaks Road
    Oadby
    LE2 5YL Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    19 Whiteoaks Road
    Oadby
    LE2 5YL Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector22768520001
    HAMPSON, Timothy Martyn Robert
    116 Nottingham Road
    Woodlinkin
    DE5 9RL Codnor
    Derbyshire
    Amministratore
    116 Nottingham Road
    Woodlinkin
    DE5 9RL Codnor
    Derbyshire
    BritishDirector22768530003
    HAMPSON, Timothy Martyn Robert
    6 Wynyard Close
    DE7 9JG Ilkeston
    Derbyshire
    Amministratore
    6 Wynyard Close
    DE7 9JG Ilkeston
    Derbyshire
    BritishDirector22768530002
    HEATH, Paul John
    56 Leicester Road
    Blaby
    LE8 4GQ Leicester
    Amministratore
    56 Leicester Road
    Blaby
    LE8 4GQ Leicester
    EnglandEnglishDirector37172440002
    HEWITT, Thomas Walter
    The White House
    Welford Road
    LE8 5WA Arnesby
    Leicestershire
    Amministratore
    The White House
    Welford Road
    LE8 5WA Arnesby
    Leicestershire
    BritishDirector113054740001
    ORRELL, Brian
    Yorkstone
    Chapel Lane, Denford
    NN14 4EA Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Yorkstone
    Chapel Lane, Denford
    NN14 4EA Kettering
    Northamptonshire
    BritishDirector6329240001
    ROGERS, Malcolm
    23 Dumbleton Avenue
    LE3 2EF Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    23 Dumbleton Avenue
    LE3 2EF Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector22768550001
    SALMONS, Peter James
    1 Appleby Close
    Redhill Grange
    NN9 5YN Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Appleby Close
    Redhill Grange
    NN9 5YN Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishCorporate Sales Director39684280001
    WILLIAMS, Colin Frederick
    3 Glenville Avenue
    Glenfield
    LE3 8BE Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    3 Glenville Avenue
    Glenfield
    LE3 8BE Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector15487390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr John Anthony Yell
    164 Barkby Road
    Leicester
    LE4 9LF
    06 apr 2016
    164 Barkby Road
    Leicester
    LE4 9LF
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Collateral debenture
    Creato il 17 mag 1996
    Consegnato il 21 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from greenshires group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg 102 up 4 colour press number 523691 located at the premises of the company at barkby road leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Collateral chattel mortgage
    Creato il 06 mag 1993
    Consegnato il 07 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from greenshires group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the plant machinery chattels or other equipment being herzog heymann greeting card folding machine serial no. M6-3296/291-19/200-274 and mbo folding machine 1989 mbo K89 4KTL machine no. 62880710 serial no. 890111348. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Collateral debenture
    Creato il 23 dic 1991
    Consegnato il 02 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from greenshires group limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 05 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of assignment the plant machinery chattels or other equipment of the company as detailed on reverse of form 395. (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 giu 1988
    Consegnato il 28 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that factory premises situate at churchgate in the city of leicester k/a 99 churchgate leicester.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 giu 1988
    Consegnato il 28 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0