GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02269409 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 164 Barkby Road Leicester LE4 9LF |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LEICESTER PRINTERS LIMITED | 20 giu 1988 | 20 giu 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jacqueline Ann Seabrook come segretario in data 31 gen 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul John Heath come amministratore in data 08 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YELL, John Anthony | Amministratore | 2 Grange Park Thurnby LE7 9QQ Leicester | England | British | Director | 6136950002 | ||||
| BRUNDELL, Paul James | Segretario | 10 Main Street Burrough On The Hill LE14 2JQ Melton Mowbray Leicestershire | British | 39106260003 | ||||||
| CARTER, Andrew | Segretario | Willowbank 16 South Street Isham NN14 1HP Kettering Northamptonshire | British | 6136900002 | ||||||
| CARTER, Andrew | Segretario | 24 Fineshade Close Barton Seagrave NN15 6SL Kettering Northamptonshire | British | 6136900001 | ||||||
| SEABROOK, Jacqueline Ann | Segretario | 4 Tokyes Close Belton In Rutland LE15 9JP Oakham Thornhill Rutland United Kingdom | British | 114015090001 | ||||||
| SEABROOK, Jacqueline Ann | Segretario | Paddock Corner Main Street LE8 0PG Shangton Leicestershire | British | 114015090001 | ||||||
| SPENCER, Christopher William | Segretario | 2 The Pinfold Markfield LE67 9QU Leicester Leicestershire | British | 102002410001 | ||||||
| FEWKES, Keith Alan | Amministratore | One Wentworth Green Kirby Muxloe LE9 2EQ Leicester Leicestershire | British | Director | 22514720001 | |||||
| GRINYER, Phillip William | Amministratore | 19 Whiteoaks Road Oadby LE2 5YL Leicester Leicestershire | British | Director | 22768520001 | |||||
| HAMPSON, Timothy Martyn Robert | Amministratore | 116 Nottingham Road Woodlinkin DE5 9RL Codnor Derbyshire | British | Director | 22768530003 | |||||
| HAMPSON, Timothy Martyn Robert | Amministratore | 6 Wynyard Close DE7 9JG Ilkeston Derbyshire | British | Director | 22768530002 | |||||
| HEATH, Paul John | Amministratore | 56 Leicester Road Blaby LE8 4GQ Leicester | England | English | Director | 37172440002 | ||||
| HEWITT, Thomas Walter | Amministratore | The White House Welford Road LE8 5WA Arnesby Leicestershire | British | Director | 113054740001 | |||||
| ORRELL, Brian | Amministratore | Yorkstone Chapel Lane, Denford NN14 4EA Kettering Northamptonshire | British | Director | 6329240001 | |||||
| ROGERS, Malcolm | Amministratore | 23 Dumbleton Avenue LE3 2EF Leicester Leicestershire | British | Director | 22768550001 | |||||
| SALMONS, Peter James | Amministratore | 1 Appleby Close Redhill Grange NN9 5YN Wellingborough Northamptonshire | British | Corporate Sales Director | 39684280001 | |||||
| WILLIAMS, Colin Frederick | Amministratore | 3 Glenville Avenue Glenfield LE3 8BE Leicester Leicestershire | England | British | Director | 15487390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr John Anthony Yell | 06 apr 2016 | 164 Barkby Road Leicester LE4 9LF | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
GREENSHIRES CREATIVE COLOUR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Collateral debenture | Creato il 17 mag 1996 Consegnato il 21 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from greenshires group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Heidelberg 102 up 4 colour press number 523691 located at the premises of the company at barkby road leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral chattel mortgage | Creato il 06 mag 1993 Consegnato il 07 mag 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from greenshires group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over the plant machinery chattels or other equipment being herzog heymann greeting card folding machine serial no. M6-3296/291-19/200-274 and mbo folding machine 1989 mbo K89 4KTL machine no. 62880710 serial no. 890111348. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral debenture | Creato il 23 dic 1991 Consegnato il 02 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from greenshires group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 24 gen 1990 Consegnato il 05 feb 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge by way of assignment the plant machinery chattels or other equipment of the company as detailed on reverse of form 395. (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 20 giu 1988 Consegnato il 28 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that factory premises situate at churchgate in the city of leicester k/a 99 churchgate leicester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 20 giu 1988 Consegnato il 28 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0