CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED

CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02271790
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    31 Hill Street
    W1J 5LS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COASTCREST LIMITED28 giu 198828 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 022717900014 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022717900013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022717900012 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 022717900014, creata il 27 gen 2021

    37 pagineMR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 022717900011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022717900010 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 022717900013, creata il 17 feb 2020

    37 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 022717900012, creata il 21 set 2018

    36 pagineMR01

    Cessazione della carica di Chanchai Ruayrungruang come amministratore in data 07 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Robert Lai come amministratore in data 02 lug 2018

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Songhua Ni come amministratore in data 30 ago 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FORSTERS SECRETARIES LIMITED
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Segretario
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03589800
    104836810001
    LAI, Robert
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    ChinaChinese248063590001
    RUAYRUNGRUANG, Woraphanit
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    ChinaThai192235480001
    COOK, Kenneth Alan
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    Segretario
    27 Glendower Road
    East Sheen
    SW14 8NY London
    British100000003
    HARRISON, Linda Christine
    87 Kimberley Road
    CR0 2PZ Croydon
    Surrey
    Segretario
    87 Kimberley Road
    CR0 2PZ Croydon
    Surrey
    British85883750001
    LAWRENCE, James Wyndham Stuart
    169 Oatland Drive
    KT13 9JY Weybridge
    Surrey
    Segretario
    169 Oatland Drive
    KT13 9JY Weybridge
    Surrey
    British101106300003
    OSBORNE, Ian
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    Segretario
    42 Brancaster Drive
    Mill Hill
    NW7 2SJ London
    British44830690006
    OGIER CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED
    Third Floor
    Equitable House, 47 King William Street
    EC4R 9JD London
    Segretario
    Third Floor
    Equitable House, 47 King William Street
    EC4R 9JD London
    121915660001
    REIGNWOOD INVESTMENTS UK LIMITED
    4 More London Riverside
    SE1 2AU London
    5th Floor
    Segretario
    4 More London Riverside
    SE1 2AU London
    5th Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione08346375
    191704470001
    BERNERD, Elliott
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    Amministratore
    58 Old Church Street
    SW3 5DB London
    British44790970001
    BROKE, Michael Haviland Adlington
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    Amministratore
    7 Westmead
    Roehampton
    SW15 5BH London
    British2996750001
    BUTLER, Robin Elliott
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    Amministratore
    Gatehouse Farm
    Rogate
    GU31 5DB Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish2996760007
    CARING, Richard Allan
    26-28 Conway Street
    London
    W1T 6BQ
    Amministratore
    26-28 Conway Street
    London
    W1T 6BQ
    EnglandBritish66036600003
    CARING, Richard Allan
    Spaniards Field
    Wildwood Rise Hampstead
    NW11 6SX London
    Amministratore
    Spaniards Field
    Wildwood Rise Hampstead
    NW11 6SX London
    EnglandBritish66036600003
    COPPERTHWAITE, Lisa Maria
    17 Chapel House Street
    Isle Of Dogs
    E14 3AS London
    Amministratore
    17 Chapel House Street
    Isle Of Dogs
    E14 3AS London
    EnglandBritish106663030001
    DEVLIN, George
    3 Mansfield Street
    W1M 9FL London
    Amministratore
    3 Mansfield Street
    W1M 9FL London
    British62513580001
    HUGILL, William Nigel
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    Amministratore
    15 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    EnglandBritish3015960006
    LAWRENCE, James Wyndham Stuart
    169 Oatland Drive
    KT13 9JY Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    169 Oatland Drive
    KT13 9JY Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish101106300003
    MINSHULL-BEECH, John Patrick
    33 Gerard Road
    SW13 9QH London
    Amministratore
    33 Gerard Road
    SW13 9QH London
    EnglandBritish85462230001
    NI, Songhua
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    United KingdomChinese189850960001
    PHILLIPS, David
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    Amministratore
    5 Glebe Place
    SW3 5LB London
    United KingdomBritish65062400001
    RUAYRUNGRUANG, Chanchai, Dr
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    Amministratore
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    ChinaThai192236000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    England
    06 apr 2016
    Hill Street
    W1J 5LS London
    31
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05455442
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 gen 2021
    Consegnato il 01 feb 2021
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited
    Transazioni
    • 01 feb 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 feb 2020
    Consegnato il 24 feb 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 24 feb 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 set 2018
    Consegnato il 25 set 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 25 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2016
    Consegnato il 19 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 19 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 set 2014
    Consegnato il 09 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Hong Kong Branch
    Transazioni
    • 09 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Permanent finance security deed
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 04 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transazioni
    • 04 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 23 ott 1997
    Consegnato il 29 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any guarantees granted by the company by way of security for chelsfield PLC's liabilities to the bank under a facility agreement of even date together with the chargee's charges and commission interest and expenses in connection therewith
    Brevi particolari
    The entire issued share capital of westbury hotel limited(no.3197648) (the "securities") and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge of securities
    Creato il 02 lug 1997
    Consegnato il 16 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any guarantees granted by the company by way of security for chelsfield's liabilities to the chargee under the facilities agreements dated 25TH march 1997 together with the chargees charges and commission interest and expenses in connection therewith
    Brevi particolari
    The entire issued share capital of westbury hotel limited (no. 3197648) (the "securities") and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 25 mar 1997
    Consegnato il 04 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any guarantees granted by the company by way of security for chelsfield PLC's liabilities to the chargee under two facility agreements dated 25TH march 1997 together with the bank's charges and commission interest and expenses in connection therewith
    Brevi particolari
    The entire issued share capital of the westbury hotel limited and chelsfield westbury llc and to deposit all documents relating to any bunus or rights or other issue of stock or shares in respect of the securities charged and to mandate to the bank all dividends distributions and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge deed
    Creato il 31 ott 1994
    Consegnato il 07 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever excluding all such monies and liabilities arising (whether directly or indirectly) under or in respect of a £60,000,000 term loan made available by the bank to chelsfield (UK) PLC under a loan agreement dated 10TH march 1992 and amended on the 7TH december 1993 and as further amended from time to time
    Brevi particolari
    All the securities referred to in the schedule being:- 9,600 b shares of £104 each in the share capital of wentworth group holdings limited, 60 £1,000 nominal unsecured undated zero coupon series b debentures created by wentworth club limited by a deed poll dated 12/10/89 and not yet issued and all dividends interest and other income deriving therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 31 ott 1994
    Consegnato il 04 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever but excluding all moneys and liabilities under or in respect of a £60,000,000 term loan made available by lloyds bank PLC to chelsfield (UK) PLC under a loan agreement dated 10TH march 1992 and amended on 7TH december 1993 and as further amended from time to time
    Brevi particolari
    The whole of the company's undertaking ,property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including any uncalled capital and future calls.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC,
    Transazioni
    • 04 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 19 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 1992
    Consegnato il 25 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0