CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02271790 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 31 Hill Street W1J 5LS London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COASTCREST LIMITED | 28 giu 1988 | 28 giu 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 022717900014 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 022717900013 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 022717900012 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 022717900014, creata il 27 gen 2021 | 37 pagine | MR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 022717900011 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 022717900010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 022717900013, creata il 17 feb 2020 | 37 pagine | MR01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 022717900012, creata il 21 set 2018 | 36 pagine | MR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Chanchai Ruayrungruang come amministratore in data 07 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Robert Lai come amministratore in data 02 lug 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Songhua Ni come amministratore in data 30 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORSTERS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Hill Street W1J 5LS London 31 |
| 104836810001 | ||||||||||
| LAI, Robert | Amministratore | Hill Street W1J 5LS London 31 | China | Chinese | 248063590001 | |||||||||
| RUAYRUNGRUANG, Woraphanit | Amministratore | Hill Street W1J 5LS London 31 | China | Thai | 192235480001 | |||||||||
| COOK, Kenneth Alan | Segretario | 27 Glendower Road East Sheen SW14 8NY London | British | 100000003 | ||||||||||
| HARRISON, Linda Christine | Segretario | 87 Kimberley Road CR0 2PZ Croydon Surrey | British | 85883750001 | ||||||||||
| LAWRENCE, James Wyndham Stuart | Segretario | 169 Oatland Drive KT13 9JY Weybridge Surrey | British | 101106300003 | ||||||||||
| OSBORNE, Ian | Segretario | 42 Brancaster Drive Mill Hill NW7 2SJ London | British | 44830690006 | ||||||||||
| OGIER CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED | Segretario | Third Floor Equitable House, 47 King William Street EC4R 9JD London | 121915660001 | |||||||||||
| REIGNWOOD INVESTMENTS UK LIMITED | Segretario | 4 More London Riverside SE1 2AU London 5th Floor |
| 191704470001 | ||||||||||
| BERNERD, Elliott | Amministratore | 58 Old Church Street SW3 5DB London | British | 44790970001 | ||||||||||
| BROKE, Michael Haviland Adlington | Amministratore | 7 Westmead Roehampton SW15 5BH London | British | 2996750001 | ||||||||||
| BUTLER, Robin Elliott | Amministratore | Gatehouse Farm Rogate GU31 5DB Petersfield Hampshire | England | British | 2996760007 | |||||||||
| CARING, Richard Allan | Amministratore | 26-28 Conway Street London W1T 6BQ | England | British | 66036600003 | |||||||||
| CARING, Richard Allan | Amministratore | Spaniards Field Wildwood Rise Hampstead NW11 6SX London | England | British | 66036600003 | |||||||||
| COPPERTHWAITE, Lisa Maria | Amministratore | 17 Chapel House Street Isle Of Dogs E14 3AS London | England | British | 106663030001 | |||||||||
| DEVLIN, George | Amministratore | 3 Mansfield Street W1M 9FL London | British | 62513580001 | ||||||||||
| HUGILL, William Nigel | Amministratore | 15 Briar Walk Putney SW15 6UD London | England | British | 3015960006 | |||||||||
| LAWRENCE, James Wyndham Stuart | Amministratore | 169 Oatland Drive KT13 9JY Weybridge Surrey | England | British | 101106300003 | |||||||||
| MINSHULL-BEECH, John Patrick | Amministratore | 33 Gerard Road SW13 9QH London | England | British | 85462230001 | |||||||||
| NI, Songhua | Amministratore | Hill Street W1J 5LS London 31 | United Kingdom | Chinese | 189850960001 | |||||||||
| PHILLIPS, David | Amministratore | 5 Glebe Place SW3 5LB London | United Kingdom | British | 65062400001 | |||||||||
| RUAYRUNGRUANG, Chanchai, Dr | Amministratore | Hill Street W1J 5LS London 31 | China | Thai | 192236000001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wga (Uk) Holdings Limited | 06 apr 2016 | Hill Street W1J 5LS London 31 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CHELSFIELD PARTICIPATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 27 gen 2021 Consegnato il 01 feb 2021 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 17 feb 2020 Consegnato il 24 feb 2020 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 21 set 2018 Consegnato il 25 set 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 19 dic 2016 Consegnato il 19 dic 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 26 set 2014 Consegnato il 09 ott 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Permanent finance security deed | Creato il 15 set 2004 Consegnato il 04 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of securities | Creato il 23 ott 1997 Consegnato il 29 ott 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under any guarantees granted by the company by way of security for chelsfield PLC's liabilities to the bank under a facility agreement of even date together with the chargee's charges and commission interest and expenses in connection therewith | |
Brevi particolari The entire issued share capital of westbury hotel limited(no.3197648) (the "securities") and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge of securities | Creato il 02 lug 1997 Consegnato il 16 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under any guarantees granted by the company by way of security for chelsfield's liabilities to the chargee under the facilities agreements dated 25TH march 1997 together with the chargees charges and commission interest and expenses in connection therewith | |
Brevi particolari The entire issued share capital of westbury hotel limited (no. 3197648) (the "securities") and all income derived from the securities and all rights attaching to the securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of securities | Creato il 25 mar 1997 Consegnato il 04 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under any guarantees granted by the company by way of security for chelsfield PLC's liabilities to the chargee under two facility agreements dated 25TH march 1997 together with the bank's charges and commission interest and expenses in connection therewith | |
Brevi particolari The entire issued share capital of the westbury hotel limited and chelsfield westbury llc and to deposit all documents relating to any bunus or rights or other issue of stock or shares in respect of the securities charged and to mandate to the bank all dividends distributions and other income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge deed | Creato il 31 ott 1994 Consegnato il 07 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever excluding all such monies and liabilities arising (whether directly or indirectly) under or in respect of a £60,000,000 term loan made available by the bank to chelsfield (UK) PLC under a loan agreement dated 10TH march 1992 and amended on the 7TH december 1993 and as further amended from time to time | |
Brevi particolari All the securities referred to in the schedule being:- 9,600 b shares of £104 each in the share capital of wentworth group holdings limited, 60 £1,000 nominal unsecured undated zero coupon series b debentures created by wentworth club limited by a deed poll dated 12/10/89 and not yet issued and all dividends interest and other income deriving therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 31 ott 1994 Consegnato il 04 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever but excluding all moneys and liabilities under or in respect of a £60,000,000 term loan made available by lloyds bank PLC to chelsfield (UK) PLC under a loan agreement dated 10TH march 1992 and amended on 7TH december 1993 and as further amended from time to time | |
Brevi particolari The whole of the company's undertaking ,property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including any uncalled capital and future calls. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 17 feb 1992 Consegnato il 19 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 feb 1992 Consegnato il 25 feb 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0