PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED

PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPEGASUS SECURITY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02272591
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KROLL ADVISORY LTD
    The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GLOBAL ALARMS LIMITED29 giu 198829 giu 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    42 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Velocity 1 Brooklands Drive Brooklands Weybridge Surrey KT13 0SL England a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 14 dic 2022

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 nov 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Cessazione di Pegasus Security Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di Iss Brightspark Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2022

    2 paginePSC02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 12 ott 2022

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    1 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Joanne Roberts come amministratore in data 22 ott 2021

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENISON, Elizabeth Michelle
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Amministratore
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    EnglandBritish283639230001
    ROBERTS, Joanne
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    Amministratore
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    EnglandBritish288760280001
    ANDERSEN, Henrik
    14 Hale End
    Hook Heath
    GU22 0LH Woking
    Surrey
    Segretario
    14 Hale End
    Hook Heath
    GU22 0LH Woking
    Surrey
    Danish106962600002
    CHAPMAN, Benedict Michael Ian
    39 Melrose Gardens
    Aborfield
    RG2 9PY Reading
    Berkshire
    Segretario
    39 Melrose Gardens
    Aborfield
    RG2 9PY Reading
    Berkshire
    British9013030001
    DUNN, Michael Frederick
    Parish Farm Barn Hassell Street
    Hastingleigh
    TN25 5JE Ashford
    Kent
    Segretario
    Parish Farm Barn Hassell Street
    Hastingleigh
    TN25 5JE Ashford
    Kent
    British31670510001
    LAWSON, John Mcpherson
    2 Meadow Court
    Netherton
    WF4 4HT Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Meadow Court
    Netherton
    WF4 4HT Wakefield
    West Yorkshire
    British16529040002
    MALTESE, Robert
    16 Mortlake House
    512 Chiswick High Road
    W4 5RH London
    Segretario
    16 Mortlake House
    512 Chiswick High Road
    W4 5RH London
    Italian60168970003
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Segretario
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    ANDERSEN, Henrik
    Iss House
    Genesis Business Park
    GU21 5RW Albert Drive Woking
    Surrey
    Amministratore
    Iss House
    Genesis Business Park
    GU21 5RW Albert Drive Woking
    Surrey
    United KingdomDanish106962600002
    BRABIN, Matthew Edward Stanley
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    Amministratore
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    EnglandBritish92458830002
    BRABIN, Matthew Edward Stanley
    12 Marshall Road
    GU7 3AS Godalming
    Surrey
    Amministratore
    12 Marshall Road
    GU7 3AS Godalming
    Surrey
    EnglandBritish92458830002
    CAPON, Graham Roger
    5 Silver Street
    Stoford
    BA22 9UF Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    5 Silver Street
    Stoford
    BA22 9UF Yeovil
    Somerset
    British9013040005
    CHAPMAN, Benedict Michael Ian
    39 Melrose Gardens
    Aborfield
    RG2 9PY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    39 Melrose Gardens
    Aborfield
    RG2 9PY Reading
    Berkshire
    British9013030001
    CHOAT, Raymond John Patrick
    79 Old Farm Avenue
    DA15 8AD Sidcup
    Kent
    Amministratore
    79 Old Farm Avenue
    DA15 8AD Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish9013050001
    DONEGAN, Simon Patrick
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    British77399210003
    HAMILTON, Stephanie Louise
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    Amministratore
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    United KingdomBritish280463790001
    JACOMB, Paul Stephen
    Lawnend Abbotts Court
    Park Road
    SO23 7BE Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Lawnend Abbotts Court
    Park Road
    SO23 7BE Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish58618550001
    LAWSON, John Mcpherson
    2 Meadow Court
    Netherton
    WF4 4HT Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Meadow Court
    Netherton
    WF4 4HT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish16529040002
    LEGG, Stephen John
    104 Percy Road
    TW12 2JW Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    104 Percy Road
    TW12 2JW Hampton
    Middlesex
    British9013060002
    LEIGH, Philip John
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    Amministratore
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    EnglandBritish156680600002
    MORAN, Alan Thomas
    Me Nelja Church Road
    Pamber Heath
    RG26 6DZ Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Me Nelja Church Road
    Pamber Heath
    RG26 6DZ Basingstoke
    Hampshire
    British9013070001
    PATEL, Purvin Kumar Madhusudan
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    Amministratore
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    EnglandBritish271205360001
    PLUCNAR JENSEN, Barbara
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    Amministratore
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    EnglandDanish216409100001
    PRICE, Andrew Simon
    Old Bonhams
    OX17 1SA Wardington
    Oxfordshire
    Amministratore
    Old Bonhams
    OX17 1SA Wardington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish290856420001
    SIMPSON, Perry Bernard
    Shiplands Farm
    Pluckley
    TN27 0PD Ashford
    Kent
    Amministratore
    Shiplands Farm
    Pluckley
    TN27 0PD Ashford
    Kent
    United KingdomNew Zealander58162580003
    SYKES, Richard Ian
    Iss House
    Genesis Business Park
    GU21 5RW Albert Drive Woking
    Surrey
    Amministratore
    Iss House
    Genesis Business Park
    GU21 5RW Albert Drive Woking
    Surrey
    United KingdomBritish93113770004
    VAN DER WAAG, Bruce Andrew
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    Amministratore
    Brooklands Drive
    Brooklands
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    Surrey
    England
    EnglandDutch195067340001
    VESTERGAARD, Jorn
    Iss House
    Genesis Business Park
    GU21 5RW Albert Drive Woking
    Surrey
    Amministratore
    Iss House
    Genesis Business Park
    GU21 5RW Albert Drive Woking
    Surrey
    United KingdomDanish198906050001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brooklands Drive
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    England
    04 nov 2022
    Brooklands Drive
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione12087539
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Brooklands Drive
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    England
    06 apr 2016
    Brooklands Drive
    KT13 0SL Weybridge
    Velocity 1
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3416816
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 19 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Deposit account with halifax PLC in the names of christopher george cowlard and pegasus security limited.
    Persone aventi diritto
    • Christopher George Cowlard
    Transazioni
    • 19 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 mag 1998
    Consegnato il 29 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1998
    Consegnato il 29 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 1 abbeville mews 88 clapham park london t/n TGL37571. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1998
    Consegnato il 29 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit A1 oldfield road hampton t/n TGL62444. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Credit agreement
    Creato il 15 lug 1993
    Consegnato il 23 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75161.80 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to all sums payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 23 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1993
    Consegnato il 13 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1 abbeville mews clapham park road lambeth t/n tgl 37571. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 apr 1993
    Consegnato il 13 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit A1 oldfield road hampton richmond upon thames t/n tgl 62444. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 07 ago 1991
    Consegnato il 15 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £49360-80 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All the right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance, particulars whereof are set out fully on form 395.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 15 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 dic 1989
    Consegnato il 22 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 nov 2022Inizio della liquidazione
    15 mar 2024Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Edward Robert Bines
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Kroll Advisory Ltd The Shard 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0