PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02272591 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | KROLL ADVISORY LTD The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GLOBAL ALARMS LIMITED | 29 giu 1988 | 29 giu 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 42 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Velocity 1 Brooklands Drive Brooklands Weybridge Surrey KT13 0SL England a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 14 dic 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Cessazione di Pegasus Security Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2022 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Iss Brightspark Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2022 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 12 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 12 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 12 ott 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 7 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Ms Joanne Roberts come amministratore in data 22 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENISON, Elizabeth Michelle | Amministratore | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | 283639230001 | |||||
| ROBERTS, Joanne | Amministratore | 32 London Bridge Street SE1 9SG London The Shard | England | British | 288760280001 | |||||
| ANDERSEN, Henrik | Segretario | 14 Hale End Hook Heath GU22 0LH Woking Surrey | Danish | 106962600002 | ||||||
| CHAPMAN, Benedict Michael Ian | Segretario | 39 Melrose Gardens Aborfield RG2 9PY Reading Berkshire | British | 9013030001 | ||||||
| DUNN, Michael Frederick | Segretario | Parish Farm Barn Hassell Street Hastingleigh TN25 5JE Ashford Kent | British | 31670510001 | ||||||
| LAWSON, John Mcpherson | Segretario | 2 Meadow Court Netherton WF4 4HT Wakefield West Yorkshire | British | 16529040002 | ||||||
| MALTESE, Robert | Segretario | 16 Mortlake House 512 Chiswick High Road W4 5RH London | Italian | 60168970003 | ||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Segretario | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||
| ANDERSEN, Henrik | Amministratore | Iss House Genesis Business Park GU21 5RW Albert Drive Woking Surrey | United Kingdom | Danish | 106962600002 | |||||
| BRABIN, Matthew Edward Stanley | Amministratore | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | 92458830002 | |||||
| BRABIN, Matthew Edward Stanley | Amministratore | 12 Marshall Road GU7 3AS Godalming Surrey | England | British | 92458830002 | |||||
| CAPON, Graham Roger | Amministratore | 5 Silver Street Stoford BA22 9UF Yeovil Somerset | British | 9013040005 | ||||||
| CHAPMAN, Benedict Michael Ian | Amministratore | 39 Melrose Gardens Aborfield RG2 9PY Reading Berkshire | British | 9013030001 | ||||||
| CHOAT, Raymond John Patrick | Amministratore | 79 Old Farm Avenue DA15 8AD Sidcup Kent | United Kingdom | British | 9013050001 | |||||
| DONEGAN, Simon Patrick | Amministratore | The Old School House Northend RG9 6LJ Henley Upon Thames Oxfordshire | British | 77399210003 | ||||||
| HAMILTON, Stephanie Louise | Amministratore | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | United Kingdom | British | 280463790001 | |||||
| JACOMB, Paul Stephen | Amministratore | Lawnend Abbotts Court Park Road SO23 7BE Winchester Hampshire | England | British | 58618550001 | |||||
| LAWSON, John Mcpherson | Amministratore | 2 Meadow Court Netherton WF4 4HT Wakefield West Yorkshire | England | British | 16529040002 | |||||
| LEGG, Stephen John | Amministratore | 104 Percy Road TW12 2JW Hampton Middlesex | British | 9013060002 | ||||||
| LEIGH, Philip John | Amministratore | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | 156680600002 | |||||
| MORAN, Alan Thomas | Amministratore | Me Nelja Church Road Pamber Heath RG26 6DZ Basingstoke Hampshire | British | 9013070001 | ||||||
| PATEL, Purvin Kumar Madhusudan | Amministratore | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | British | 271205360001 | |||||
| PLUCNAR JENSEN, Barbara | Amministratore | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | Danish | 216409100001 | |||||
| PRICE, Andrew Simon | Amministratore | Old Bonhams OX17 1SA Wardington Oxfordshire | United Kingdom | British | 290856420001 | |||||
| SIMPSON, Perry Bernard | Amministratore | Shiplands Farm Pluckley TN27 0PD Ashford Kent | United Kingdom | New Zealander | 58162580003 | |||||
| SYKES, Richard Ian | Amministratore | Iss House Genesis Business Park GU21 5RW Albert Drive Woking Surrey | United Kingdom | British | 93113770004 | |||||
| VAN DER WAAG, Bruce Andrew | Amministratore | Brooklands Drive Brooklands KT13 0SL Weybridge Velocity 1 Surrey England | England | Dutch | 195067340001 | |||||
| VESTERGAARD, Jorn | Amministratore | Iss House Genesis Business Park GU21 5RW Albert Drive Woking Surrey | United Kingdom | Danish | 198906050001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iss Brightspark Limited | 04 nov 2022 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Pegasus Security Holdings Limited | 06 apr 2016 | Brooklands Drive KT13 0SL Weybridge Velocity 1 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 01 ott 1999 Consegnato il 19 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £50,000 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Deposit account with halifax PLC in the names of christopher george cowlard and pegasus security limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 mag 1998 Consegnato il 29 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 mag 1998 Consegnato il 29 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H unit 1 abbeville mews 88 clapham park london t/n TGL37571. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 mag 1998 Consegnato il 29 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H unit A1 oldfield road hampton t/n TGL62444. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 15 lug 1993 Consegnato il 23 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £75161.80 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to all sums payable under the insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 apr 1993 Consegnato il 13 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 1 abbeville mews clapham park road lambeth t/n tgl 37571. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 06 apr 1993 Consegnato il 13 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit A1 oldfield road hampton richmond upon thames t/n tgl 62444. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 07 ago 1991 Consegnato il 15 ago 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £49360-80 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All the right title & interest in & to all sums payable (including by way of refund) under the insurance, particulars whereof are set out fully on form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 dic 1989 Consegnato il 22 dic 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
PEGASUS SECURITY GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0