EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02276013 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| APTA HEALTHCARE (NOTTINGHAM) LIMITED | 03 gen 1995 | 03 gen 1995 |
| REALCARE HOMES LIMITED | 21 nov 1988 | 21 nov 1988 |
| RIMFORGE LIMITED | 11 lug 1988 | 11 lug 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| BAKER, Graham | Segretario | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | 40240710001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Segretario | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Segretario | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Segretario | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Segretario | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| LOUKES, Kenneth Martin | Segretario | 23 The Chase HA7 3RU Stanmore Middlesex | British | 6945830001 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Segretario | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158306100001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Segretario | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Segretario | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SMITH, Peter Anthony | Segretario | Forge Cottage Forge Lane, Shorne DA12 3DP Gravesend Kent | British | 71842080001 | ||||||
| SPEIRS, Lesley Sarah | Segretario | 22 Douglas Park Crescent Bearsden G61 3DT Glasgow Lanarkshire | British | 69112020001 | ||||||
| ABLETT, Julie | Amministratore | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BAKER, Graham | Amministratore | 26 Hazelhurst Road Kings Heath B14 7PJ Birmingham West Midlands | British | 40240710001 | ||||||
| BALLANTYNE, Thomas Niven | Amministratore | Greystones Milnthorpe Road, Holme LA6 1PX Carnforth Lancashire | England | British | 68970050002 | |||||
| BARLOW, George Edward | Amministratore | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Amministratore | Pipers Cottage Grove Heath Road Ripley GU23 6EU Woking Surrey | American | 51593550001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FARMER, Nicholas John | Amministratore | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FARRALL, Elaine Ann | Amministratore | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Amministratore | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Amministratore | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GEE, Andrew Anthony Edward | Amministratore | 83a Sutherland Avenue TN16 3HG Biggin Hill Kent | England | British | 93592160001 | |||||
| GOSLING, Mark David | Amministratore | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| GWATKIN, Peter Frederick Stapleton | Amministratore | Shustoke Hall Moathouse Lane Shustoke Coleshill B46 2RJ Birmingham | British | 42082340004 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Amministratore | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Amministratore | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Amministratore | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| LOUKES, Kenneth Martin | Amministratore | 23 The Chase HA7 3RU Stanmore Middlesex | British | 6945830001 |
EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 23 mar 1998 Consegnato il 09 apr 1998 | In corso | Importo garantito The obligations of the company to the chargee in a lease dated 23RD march 1998 | |
Brevi particolari A deposit of £74,500 (initially) which will during the life of the rent deposit deed be increased as set out in the rent deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 23 mar 1998 Consegnato il 07 apr 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Inclusive of the l/h interest of the company in and to the "legal charge property" k/a site 5B2, copperfield road thamesmead all fixtures and the proceeds of sale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 feb 1996 Consegnato il 14 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Mortgage 8,9 and 10 third avenue sherwood drive nottingham t/n's NT19209 and NT30826 all buildings and other structures any goodwill all olant macinery and items the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums and by way of floating charge all unattached plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 feb 1996 Consegnato il 14 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The chestnuts hotel main road rasdcliffe on trent nottinghamshire t/n NT155409 by way of fixed charge all buildings and structures by way of fixed charge any goodwill all plant machinery and other items and the proceeds of any claims under the insurances by way of assignment the rental sums by way of floating charge all unattached plant machinery and chattels. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 dic 1995 Consegnato il 12 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 ago 1995 Consegnato il 17 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The properties as detailed in the continuation sheet attached to the form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 gen 1995 Consegnato il 07 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H-willow court nursing home being land on the east side of croft lane, cherry willingham, west lindsey lincolnshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 gen 1995 Consegnato il 07 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H-white gables nursing home lincoln road skellingthorpe and land at skellingthorpe, north kesteven lincolnshire t/n-LL54775 and LL73989. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 gen 1995 Consegnato il 07 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H-wood view nursing home being land on the south west side and land and buildings lying to the south west of lincoln road and being 127 lincoln road branston north kesteven lincolnshire t/n-LL91827 and LL93202. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 gen 1995 Consegnato il 07 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H-willow court nursing home being land on east side of croft lane cherry willingham west lindsey lincolneshire t/n-LL88541. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture | Creato il 24 dic 1991 Consegnato il 07 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the security documents as defined | |
Brevi particolari See doc ref M560C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
EXCELER HEALTHCARE SERVICES LEASING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0