INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02281555 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
- Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari
Dove si trova INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 High Street RG19 3JG Thatcham Berks England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RACESWITCH LIMITED | 28 lug 1988 | 28 lug 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 04 mag 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 18 mag 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 04 mag 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nomina di Mr Andrew John Piper come amministratore in data 31 ott 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di John Edward Castell come amministratore in data 31 ott 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2024 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Bloch come amministratore in data 25 mar 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Maybrook Properties Limited come amministratore in data 25 mar 2025 | 2 pagine | AP02 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Bloch il 23 gen 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Edward Castell il 23 gen 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Rsm, 2nd Floor One the Square Temple Quay Bristol BS1 6DG United Kingdom a 1 High Street Thatcham Berks RG19 3JG in data 06 feb 2025 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2023 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2022 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2023 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2021 | 3 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Edward Castell il 19 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Rsm 4th Floor, Hartwell House 55-61 Victoria Street Bristol BS1 6AD United Kingdom a Rsm, 2nd Floor One the Square Temple Quay Bristol BS1 6DG in data 13 giu 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Rsm Uk Tax and Accounting Limited Hermes House Fire Fly Avenue Swindon Wiltshire SN2 2GA England a Rsm 4th Floor, Hartwell House 55-61 Victoria Street Bristol BS1 6AD in data 18 nov 2021 | 1 pagine | AD01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Edward Castell il 30 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2020 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2019 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Wilkins Kennedy Anglo House Bell Lane Office Village Bell Lane Amersham Buckinghamshire HP6 6FA United Kingdom a Rsm Uk Tax and Accounting Limited Hermes House Fire Fly Avenue Swindon Wiltshire SN2 2GA in data 30 set 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Amersham Corporate Services Limited come segretario in data 10 set 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Chi sono gli amministratori di INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER, Andrew John | Amministratore | RG19 3JG Thatcham 1 High Street Berks England | England | British | 230994780001 | |||||||||
| MAYBROOK PROPERTIES LIMITED | Amministratore | 3rd Floor EC2M 5TF London 43 London Wall England |
| 334433740001 | ||||||||||
| DAVIES, Maureen | Segretario | Parcmnys 186 Tivoli Crescent North BN1 5NA Brighton East Sussex | British | 60615220001 | ||||||||||
| HOBBS, John Quentin | Segretario | 81 Corinium Gate GL7 2PX Cirencester Gloucestershire | British | 97299360001 | ||||||||||
| KELLY, Gerard Patrick | Segretario | 3 Beechcroft Avenue CR8 5JZ Kenley Surrey | British | 1019750001 | ||||||||||
| MOTE, Henry Anthony | Segretario | Chilt Cottage Heather Lane West Chiltington RH20 2NZ Pulborough West Sussex | British | 2745990001 | ||||||||||
| NLAMEY, Raymond Charles | Segretario | The Orchard 382 Upper Shoreham Road BN43 5ND Shoreham By Sea West Sussex | British | 5499230002 | ||||||||||
| SCARR, Peter Gervase Renforth | Segretario | 3 Priory Green Highworth SN6 7NU Swindon Wiltshire | British | 44131610001 | ||||||||||
| WHITE, Christopher David | Segretario | 7 Kirkstall Road SW2 4HD London | British | 64515870001 | ||||||||||
| AMERSHAM CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | Bell Lane Office Village Bell Lane HP6 6FA Amersham Anglo House Buckinghamshire United Kingdom | 87921930002 | |||||||||||
| BLOCH, Timothy | Amministratore | RG19 3JG Thatcham 1 High Street Berks England | United Kingdom | British | 123421590003 | |||||||||
| CASTELL, John Edward | Amministratore | RG19 3JG Thatcham 1 High Street Berks England | England | British | 8037420001 | |||||||||
| CLEVERLEY, Russell John | Amministratore | Elcombe Hall Elcombe SN4 9JU Swindon Wiltshire | England | British | 26265100001 | |||||||||
| COOKNELL, Robert James | Amministratore | Soho Square W1D 3PZ London 4-6 United Kingdom | England | British | 180227740001 | |||||||||
| GREEN, Michael David | Amministratore | Stonewell House 64 Victoria Road BA14 7LD Trowbridge Wiltshire | British | 67796070001 | ||||||||||
| HAWLEY, Guy | Amministratore | Leigh SN6 6RQ Swindon Trefoil Wiltshire England | England | British | 158503350002 | |||||||||
| HAYNES, John Stuart Richard | Amministratore | 41 Main Street Congerstone CV13 6LZ Nuneaton | England | British | 60348440002 | |||||||||
| HENDERSON, Donald Cruden | Amministratore | March Hare Cottage Elm Corner Ockham Woking GU23 6PX Guildford Surrey | British | 2917110002 | ||||||||||
| JAMES, Chris | Amministratore | Halapeno High High Street GL7 5UG South Cerney Gloucestershire | British | 85251870001 | ||||||||||
| KELLY, Gerard Patrick | Amministratore | 3 Beechcroft Avenue CR8 5JZ Kenley Surrey | British | 1019750001 | ||||||||||
| LONG, Peter Cyril | Amministratore | Kynance 116 Meeting House Lane CV7 7GE Balsall Common Coventry | British | 33291310001 | ||||||||||
| LUDLOW, Paul Arnott | Amministratore | Hockhams Farm Hockhams Lane WR6 6QR Martley Worcestershire | England | British | 38079780004 | |||||||||
| MCCOMBIE, Brian Geoffrey | Amministratore | Stonecroft 22 Summer Gardens GU15 1ED Camberley Surrey | British | 4527370001 | ||||||||||
| NLAMEY, Raymond Charles | Amministratore | The Orchard 382 Upper Shoreham Road BN43 5ND Shoreham By Sea West Sussex | British | 5499230002 | ||||||||||
| NOTTAGE, Jonathan Bruce | Amministratore | Shelland House SN14 8LT Marshfield South Gloucestershire | United Kingdom | British | 130871380001 | |||||||||
| SMYTHE, Edward Winston John | Amministratore | Milford House Oriel Close BA14 7RB Halperton Wiltshire | British | 26601720001 | ||||||||||
| SPRAY, Richard Anthony | Amministratore | 6 Saint Michaels House Priory Road OX12 9DE Wantage Oxfordshire | United Kingdom | British | 67568970001 | |||||||||
| TALLON, Robert | Amministratore | Old Hall House Brokenborough SN16 0HZ Malmesbury Wiltshire | British | 67796000001 | ||||||||||
| WHICHELOE, Adrian | Amministratore | 5 Harley Place Clifton BS8 3JT Bristol | United Kingdom | British | 10900280001 | |||||||||
| WILLIAMS, Henry Griffith Rees | Amministratore | Cedar Cottage Upper Way MK17 9AZ Great Brickhill Buckinghamshire | England | British | 78747120001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per INTERFACE (WOOTTON BASSETT) MANAGEMENT COMPANY LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 04 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0