POOLE INVESTMENTS LIMITED

POOLE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOOLE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02282021
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POOLE INVESTMENTS PLC22 ott 200422 ott 2004
    PILKINGTON'S TILES GROUP PLC18 ago 199818 ago 1998
    QUILIGOTTI PLC27 feb 198927 feb 1989
    FALLRACE LIMITED29 lug 198829 lug 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2022
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al17 lug 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma31 lug 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al17 lug 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    5 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    50 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    10 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Burnham Yard London End Beaconsfield HP9 2JH England a 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU in data 17 ott 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di Nishith Malde come amministratore in data 04 set 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Desmond Richard Wicks come amministratore in data 04 ago 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jolyon Leonard Harrison come amministratore in data 24 lug 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 022820210018 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Sally Kenward come segretario in data 10 feb 2023

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Donagh O'sullivan come amministratore in data 16 gen 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Donagh O'sullivan come amministratore in data 06 dic 2022

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Desmond Richard Wicks come amministratore in data 14 ott 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Desmond Wicks come amministratore in data 30 set 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Sally Kenward come segretario in data 26 set 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nishith Malde come segretario in data 26 set 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Nishith Malde come segretario in data 15 ago 2022

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Kathryn Worth come segretario in data 15 ago 2022

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 set 2021

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Gary John Skinner come amministratore in data 05 apr 2022

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARRISON, Jolyon
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritishDirector235132810001
    BEARDMORE, John Denis
    8 Oakley Close
    CW11 1RQ Sandbach
    Cheshire
    Segretario
    8 Oakley Close
    CW11 1RQ Sandbach
    Cheshire
    BritishAccountant33971260001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Segretario
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    BritishDirector118171450001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Segretario
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director118171450001
    CAHILL, Thomas Gerard
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    Segretario
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    BritishCompany Director32607500001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Segretario
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Dir77855520001
    HYLAND, Melanie Patricia
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    Segretario
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    227999990001
    KENWARD, Sally
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Segretario
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    300527560001
    MALDE, Nishith
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Segretario
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    299267920001
    MALDE, Nishith
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    Segretario
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    BritishDirector148459300001
    QUINLAN, Michael John
    19 Old Church Lane
    Kingsbury
    NW9 8TG London
    Segretario
    19 Old Church Lane
    Kingsbury
    NW9 8TG London
    British5570260001
    ROBERTS, Timothy Guy
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    Segretario
    Honeycroft
    1 Gaddum Road
    WA14 3PD Bowdon
    Cheshire
    BritishDirector127918950001
    WORTH, Kathryn
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Segretario
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    258014030001
    ALLAN, William Campbell
    34 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    Amministratore
    34 Smith Street
    Chelsea
    SW3 4EP London
    EnglandBritishChartered Accountant84460001
    BOOTH, David John
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    10 Armitage Court
    Sunninghill
    SL5 9TA Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector118171450001
    BRASSINGTON, Jeremy Guy
    Hightrees Wood Riding
    Pyrford Woods
    GU22 8RH Woking
    Surrey
    Amministratore
    Hightrees Wood Riding
    Pyrford Woods
    GU22 8RH Woking
    Surrey
    BritishCompany Director35912620002
    BRETT, Paul Richard
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    Buckinghamshire
    England
    United KingdomBritishDirector105377400002
    CAHILL, Thomas Gerard
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    Amministratore
    2 Everleigh Close
    Harwood
    BL2 3HE Bolton
    Lancs
    BritishCompany Director32607500001
    CICUREL, David Elie
    18 Cavendish Avenue
    NW8 9JE London
    Amministratore
    18 Cavendish Avenue
    NW8 9JE London
    EnglandBritishCompany Director70056130003
    CROWTHER, Ian
    8 Stanneybrook Close
    Norley
    WA6 8PZ Cheshire
    Amministratore
    8 Stanneybrook Close
    Norley
    WA6 8PZ Cheshire
    BritishDirector31205800002
    DOVE, Michael Leslie
    Dales Lodge 10 Oldfield Gardens
    Heswall
    L60 6TG Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Dales Lodge 10 Oldfield Gardens
    Heswall
    L60 6TG Wirral
    Merseyside
    BritishCompany Director12007310001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Amministratore
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    AustralianDirector28868820001
    FENHALLS, Richard Dorian
    15
    St James Gardens
    W11 4RE London
    Amministratore
    15
    St James Gardens
    W11 4RE London
    BritishDirector33917200001
    HESKETH, Mark James
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    19 Littlecote Gardens
    Appleton
    WA4 5DL Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Dir77855520001
    HODGSON, Kenneth Reid Theophilus
    4 North Park
    SL9 8JW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    4 North Park
    SL9 8JW Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director4467930001
    HORNER, David Alistair
    90 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RL London
    Amministratore
    90 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RL London
    BritishCompany Director79690220001
    HUGHES, Mary-Lorraine, Dr
    12 Dingle Lane
    CW11 1FY Sandbach
    Cheshire
    Amministratore
    12 Dingle Lane
    CW11 1FY Sandbach
    Cheshire
    EnglandBritishDirector67402160001
    JENKINS, Roy Hunter, Dr
    Hale Road
    Hale Barns
    WA15 8TG Altrincham
    Ivy House, 367
    Amministratore
    Hale Road
    Hale Barns
    WA15 8TG Altrincham
    Ivy House, 367
    United KingdomBritishDirector134130590001
    JOHNSON, David Charles
    6 Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    England
    Amministratore
    6 Wilton Crescent
    SW1X 8RN London
    England
    BritishDirector42175350001
    KALBORG, Ted Gunnar Christer
    22 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    Amministratore
    22 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    EnglandSwedishDirector8637550001
    MALDE, Nishith
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Amministratore
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    EnglandBritishDirector148459300001
    MCENHILL, Raymond Peter
    Burroughs Hill Duck Lane
    Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Burroughs Hill Duck Lane
    Laverstock
    SP1 1PU Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director54190500001
    O'SULLIVAN, Donagh
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    Amministratore
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    EnglandIrishChief Executive189234530001
    PAINE, Robert Arthur
    Beechfield Yealand Conyers
    Lancaster
    LA5 9SG Lancashire
    Amministratore
    Beechfield Yealand Conyers
    Lancaster
    LA5 9SG Lancashire
    EnglandBritishDirector53861730001
    PALMER, Horace Anthony
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Fairfield London Road
    Sunninghill
    SL5 0PH Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector45646020002

    Chi sono le persone con controllo significativo di POOLE INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Inland Homes Plc
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    England
    06 apr 2016
    Chiltern Avenue
    HP6 5FG Amersham
    Decimal Place
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Acts
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    06 apr 2016
    London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Burnham Yard
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEnglad
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08775582
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    POOLE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 feb 2022
    Consegnato il 14 feb 2022
    In corso
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Eric John Spencer Gadsden
    Transazioni
    • 14 feb 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 ott 2020
    Consegnato il 12 nov 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Ground floor unit, read house, stabler way, poole BH15 4FA (title number: DT436416). For further details of properties charged, please see schedule 2 of the deed.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mct (Properties) Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 ott 2020
    Consegnato il 29 ott 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Land forming part of land lying to the north east of blandford road, poole, BH15 4AR shown edged red on the plan attached to the charge and registered at H.M. land registry as title number DT413396.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • W E Black Finance Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 dic 2019
    Consegnato il 03 gen 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Land forming part of the former pilkingtons tiles LTD, blandford road, poole, BH15 4AR registered at H.M. land registry under title number DT235032 and DT302424.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • W. E. Black Finance Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 dic 2019
    Consegnato il 02 gen 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Land forming part of the former pilkingtons tiles LTD, blandford road, poole, BH15 4AR registered at H.M. land registry under title numbers DT235032 and DT302424.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • W. E. Black Finance Limited
    Transazioni
    • 02 gen 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 28 giu 2019
    Consegnato il 16 lug 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Inland Zdp PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 giu 2019
    Consegnato il 16 lug 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Inland Zdp PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 giu 2018
    Consegnato il 02 lug 2018
    In corso
    Breve descrizione
    Part of land at pilkingtons tiles limited, blandford road, poole, dorset BH15 4AR registered at the land registry under freehold title number DT235032.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Mct (Properties) Limited
    Transazioni
    • 02 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 lug 2016
    Consegnato il 06 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The freehold property known as or being part of. Carters quay, poole, BH15 4AR and registered at. Land registry with title number DT235032.. Please see charge instrument for detail of further. Property.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 giu 2015
    Consegnato il 01 lug 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Park house, 38 station road, loudwater HP10 9UF - title number BM22498.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 01 lug 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 mar 2015
    Consegnato il 19 mar 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    O-bit house, station road, loudwater HP10 9UF - title number BM22498.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 19 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 giu 2013
    Consegnato il 04 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    DT235032 and DT302424 poole: land at blandford road poole dorset but excluding the land shown edged red on the plan annexed to the supplemental security deed and 28 blandford road poole dorset.
    Persone aventi diritto
    • Inland Zdp PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2009
    Consegnato il 03 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at lower hamworthy t/n DT235032, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2009
    Consegnato il 03 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    28 blandford road poole t/n DT302424, by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 giu 2009
    Consegnato il 12 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 09 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings at lower hamworthy poole t/no DT235032 floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment present and future.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 08 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a 28 blandford road, poole, dorset t/n:DT302424 and the f/h property k/a land and buildings at lower hamworthy, poole, dorset t/n:DT235032. By way of fixed charge all fixtures and fixed plant, machinery and equipment, the benefit to the company of all covenants, rights and agreements.
    Persone aventi diritto
    • Kevin Whiteley
    Transazioni
    • 08 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    28 blandford road poole t/no DT302424 floating charge all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment present and future.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 feb 2004
    Consegnato il 14 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 14 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 feb 2004
    Consegnato il 11 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 18 lug 1997
    Consegnato il 06 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £1,804,782 credited to account/designation 20133764 with the bank and any addition to that deposit.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 lug 1997
    Consegnato il 30 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 dic 1989
    Consegnato il 21 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 28 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    POOLE INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 ott 2023Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Lewis Armstrong
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    David Paul Hudson
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0