EUROSIGNS (UK) LIMITED

EUROSIGNS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEUROSIGNS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02283390
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    • Costruzione di strade e autostrade (42110) / Costruzioni

    Dove si trova EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RINGWAY SIGNS LIMITED27 ott 198827 ott 1988
    CORINFIELD LIMITED03 ago 198803 ago 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    31 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    11 pagineAM16

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ a Riverside House Irwell Street Manchester M3 5EN in data 02 gen 2020

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    32 pagineAM10

    Cessazione della carica di Demis Armen Ohandjanian come amministratore in data 22 mar 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Demis Armen Ohandjanian come amministratore in data 22 mar 2019

    2 pagineAP01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    45 pagineAM03

    Cessazione della carica di Chris Napier come amministratore in data 29 nov 2018

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Winterstoke Road Weston-Super-Mare Somerset BS24 9BQ United Kingdom a Tower 12 18-22 Bridge Street Spinningfields Manchester M3 3BZ in data 10 dic 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di David Anthony Myles come amministratore in data 23 nov 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 022833900005 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 022833900005, creata il 17 set 2018

    27 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022833900004, creata il 14 set 2018

    25 pagineMR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Modifica dei dettagli di Timec Group Limited come persona con controllo significativo il 26 feb 2018

    2 paginePSC05

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 lug 2018

    • Capitale: GBP 100,000.00
    3 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LYSIONEK, Susan Mary
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    British78777420001
    NORTON, Peter John
    Acorn Lodge
    Old Brighton Road
    RH11 9AJ Pease Pottage
    West Sussex
    Segretario
    Acorn Lodge
    Old Brighton Road
    RH11 9AJ Pease Pottage
    West Sussex
    British2386180002
    WITHERS, Robin William
    19 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    Segretario
    19 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British9465040003
    ATKINSON, Dixon John
    The Captains House 41 Fedden Village
    Nore Road
    BS20 8EJ Portishead
    Somerset
    Amministratore
    The Captains House 41 Fedden Village
    Nore Road
    BS20 8EJ Portishead
    Somerset
    British38942560001
    BATUT, Gregoire Claude Albert
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    EnglandFrench162291590002
    CROSS, Eric Robert Ian
    The Coach House
    The Green Shamley Green
    GU5 0UA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    The Coach House
    The Green Shamley Green
    GU5 0UA Guildford
    Surrey
    EnglandBritish94282240001
    FORSTER, Lindsay
    Grange Paddock
    Mark
    TA9 4RW Nr Highbridge
    22
    Somerster
    Uk
    Amministratore
    Grange Paddock
    Mark
    TA9 4RW Nr Highbridge
    22
    Somerster
    Uk
    British137387850001
    GIROD, Claude
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    FranceFrench161338090001
    GIROD, Philippe, Monsieur
    Belle Fontaine
    FOREIGN Morez 39400
    France
    Amministratore
    Belle Fontaine
    FOREIGN Morez 39400
    France
    FranceFrench29409290001
    GIROD, Signaux
    Bellefontaine
    Morez 39400
    France
    Amministratore
    Bellefontaine
    Morez 39400
    France
    FranceFrench29409300002
    GREGG, Richard
    10 Middlecroft
    CH3 7HF Guilden Sutton
    Cheshire
    Amministratore
    10 Middlecroft
    CH3 7HF Guilden Sutton
    Cheshire
    United KingdomBritish148915490001
    LEE, David
    9 Halyards
    Ferry Road Topsham
    EX3 0JT Exeter
    Devon
    Amministratore
    9 Halyards
    Ferry Road Topsham
    EX3 0JT Exeter
    Devon
    United KingdomBritish50707250001
    LUNDY, David Jonathan
    5 Churchward Road
    Worle
    BS22 0YX Weston Super Mare
    Avon
    Amministratore
    5 Churchward Road
    Worle
    BS22 0YX Weston Super Mare
    Avon
    British75524660001
    MYLES, David Anthony
    Weston-Super-Mare
    BS24 9BQ Somerset
    Winterstoke Road
    United Kingdom
    Amministratore
    Weston-Super-Mare
    BS24 9BQ Somerset
    Winterstoke Road
    United Kingdom
    EnglandBritish196253820001
    NAPIER, Chris
    18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Tower 12
    Amministratore
    18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Tower 12
    United KingdomBritish243426830001
    NEWLAND, Alan Henry
    21 Ocean Drive
    Ferring
    BN12 5QN Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    21 Ocean Drive
    Ferring
    BN12 5QN Worthing
    West Sussex
    British21567800001
    NORTON, Peter John
    Acorn Lodge
    Old Brighton Road
    RH11 9AJ Pease Pottage
    West Sussex
    Amministratore
    Acorn Lodge
    Old Brighton Road
    RH11 9AJ Pease Pottage
    West Sussex
    British2386180002
    OHANDJANIAN, Demis Armen
    The Mill Lane
    Glenfield
    LE3 8DX Leicester
    C/O Gssl Mill Lane Industrial Estate,
    England
    Amministratore
    The Mill Lane
    Glenfield
    LE3 8DX Leicester
    C/O Gssl Mill Lane Industrial Estate,
    England
    United KingdomBritish118283730007
    OHANDJANIAN, Demis Armen
    Mill Lane Industrial Estate
    LE3 8DX Glenfield
    C/O Glenfield Storage Solutions Limited
    Leicester
    United Kingdom
    Amministratore
    Mill Lane Industrial Estate
    LE3 8DX Glenfield
    C/O Glenfield Storage Solutions Limited
    Leicester
    United Kingdom
    United KingdomBritish118283730007
    PENNOCK, Roger James
    Bashurst Copse
    RH13 0NZ Itchingfield
    Wildacres
    West Sussex
    Amministratore
    Bashurst Copse
    RH13 0NZ Itchingfield
    Wildacres
    West Sussex
    United KingdomBritish138095250001
    ROBERTS, Peter
    TA5 1JB Over Stowey
    Pear Tree Farm
    Somerset
    Amministratore
    TA5 1JB Over Stowey
    Pear Tree Farm
    Somerset
    British136572690001
    SULLIOT, Patrick
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    UkFrench120511630003
    WARDROP, Scott Alexander
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Albion House
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish60380650003
    WILLIS, Simon Lloyd
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    Albion House
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    Albion House
    West Sussex
    England
    EnglandEnglish117465520002
    WITHERS, Robin William
    19 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    Amministratore
    19 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British9465040003

    Chi sono le persone con controllo significativo di EUROSIGNS (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Winterstoke Road
    BS24 9BQ Weston-Super-Mare
    Eurosigns (Uk) Limited
    England
    14 feb 2018
    Winterstoke Road
    BS24 9BQ Weston-Super-Mare
    Eurosigns (Uk) Limited
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09917441
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Eurovia Uk Limited
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    Albion House
    England
    24 dic 2016
    Springfield Road
    RH12 2RW Horsham
    Albion House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione2884116
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EUROSIGNS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 set 2018
    Consegnato il 24 set 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 14 set 2018
    Consegnato il 21 set 2018
    In corso
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage, all land (as defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01 ).. in the debenture “land” means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant’s fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal mortgage
    Creato il 23 feb 1993
    Consegnato il 25 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that land and premises at old mixon winterstoke rd,weston super mare,avon............and the proceeds of sale thereof; goodwill of business................see company's microfiche for details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 mag 1990
    Consegnato il 12 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a: plot 25 warne road winterstoke commercial estate weston super mare avon and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 nov 1988
    Consegnato il 02 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EUROSIGNS (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 nov 2018Inizio dell'amministrazione
    26 nov 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Poxon
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praticante
    Tower 12 Manchester House 18/22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Julien Robert Irving
    Tower 12 Manchester House 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Praticante
    Tower 12 Manchester House 18-22 Bridge Street
    Spinningfields
    M3 3BZ Manchester
    Mike Dillon
    Leonard Curtis Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester
    Praticante
    Leonard Curtis Riverside House
    Irwell Street
    M3 5EN Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0