AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED

AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02283524
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?

    • Produzione di amidi e derivati dell'amido (10620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4b Christchurch House Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    Kent
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di John Nagle come segretario in data 14 dic 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Nagle come amministratore in data 14 dic 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Douglas Arnold Corbishley come amministratore in data 13 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 mar 2016

    7 pagineAAMD

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mar 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Kirby il 10 ago 2016

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 7 Monkswell Park Manse Lane Knaresborough North Yorkshire HG5 8NQ a 4B Christchurch House Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate Rochester Kent ME2 4FX in data 26 lug 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Christopher Malcolm Terry come amministratore in data 18 gen 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Nagle come segretario in data 18 gen 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher Malcolm Terry come segretario in data 18 gen 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2016

    Stato del capitale al 04 gen 2016

    • Capitale: GBP 4,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2015

    Stato del capitale al 12 gen 2015

    • Capitale: GBP 4,000
    SH01

    Cessazione della carica di Neil Maurice Dyer come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KIRBY, Michael James
    Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    4b Christchurch House
    Kent
    England
    Amministratore
    Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    4b Christchurch House
    Kent
    England
    United KingdomBritish49079440007
    BLACKETT, Colin
    2 Rowallane Gardens
    Ingleby Barwick
    TS17 0YQ Stockton On Tees
    Cleveland
    Segretario
    2 Rowallane Gardens
    Ingleby Barwick
    TS17 0YQ Stockton On Tees
    Cleveland
    British55782360001
    BROTHERTON, Colin Michael
    30 Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    Yorkshire
    Segretario
    30 Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    Yorkshire
    British2175870001
    CLARK, Carol Jane
    36 Ellesborough Road
    Wendover
    HP22 6EL Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    36 Ellesborough Road
    Wendover
    HP22 6EL Aylesbury
    Buckinghamshire
    British30876290002
    NAGLE, John
    Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    4b Christchurch House
    Kent
    England
    Segretario
    Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    4b Christchurch House
    Kent
    England
    204360410001
    NAGLE, John
    Lower Grange
    Newington
    OX10 7AA Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    Lower Grange
    Newington
    OX10 7AA Wallingford
    Oxfordshire
    British110378680001
    REID-RUTHERFORD, Brian Walter
    The Glebe Broad Way
    Uffington
    SN7 7QH Faringdon
    Oxfordshire
    Segretario
    The Glebe Broad Way
    Uffington
    SN7 7QH Faringdon
    Oxfordshire
    British46141050002
    TERRY, Christopher Malcolm
    Unit 7 Monkswell Park
    Manse Lane
    HG5 8NQ Knaresborough
    North Yorkshire
    Segretario
    Unit 7 Monkswell Park
    Manse Lane
    HG5 8NQ Knaresborough
    North Yorkshire
    184209270001
    WILFORD, Roy
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    Segretario
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    British76263740001
    BEGY, Roger Bilton
    Lindow Cottage
    25 Main Street Greetham
    LE15 7NJ Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Lindow Cottage
    25 Main Street Greetham
    LE15 7NJ Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish96584330001
    BROTHERTON, Colin Michael
    30 Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    Yorkshire
    Amministratore
    30 Firs Drive
    HG2 9HB Harrogate
    Yorkshire
    British2175870001
    CORBISHLEY, Douglas Arnold
    Site 51 Comp 10 Rr \ 1
    Okdnagon Falls
    VOH 1RO British Columbia
    Canada
    Amministratore
    Site 51 Comp 10 Rr \ 1
    Okdnagon Falls
    VOH 1RO British Columbia
    Canada
    CanadaCanadian84156620003
    DALTON, James Matthew Percy
    The Old Mistal
    Rigton Gates Farm North Rigton
    LS17 0DR Leeds
    Amministratore
    The Old Mistal
    Rigton Gates Farm North Rigton
    LS17 0DR Leeds
    EnglandBritish22602880001
    DUFFETT, William Harold
    6 Leigh Close
    Westbury Leigh
    BA13 3SX Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    6 Leigh Close
    Westbury Leigh
    BA13 3SX Westbury
    Wiltshire
    British52510650001
    DYER, Neil Maurice
    7 Wakes Meadow
    Bunbury
    CW6 9SH Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    7 Wakes Meadow
    Bunbury
    CW6 9SH Tarporley
    Cheshire
    EnglandUnited Kingdom71140500001
    FIRTH, Michael Roger
    Lamb Hall Road
    Longwood
    HD3 3TH Huddersfield
    Lower Snow Lea Farm
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lamb Hall Road
    Longwood
    HD3 3TH Huddersfield
    Lower Snow Lea Farm
    West Yorkshire
    EnglandBritish134543140001
    NAGLE, John
    Lower Grange
    Newington
    OX10 7AA Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Lower Grange
    Newington
    OX10 7AA Wallingford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish110378680001
    TERRY, Christopher Malcolm, Mr.
    Unit 7 Monkswell Park
    Manse Lane
    HG5 8NQ Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Unit 7 Monkswell Park
    Manse Lane
    HG5 8NQ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish60746700002
    WILFORD, Roy
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    Amministratore
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    British76263740001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Specialty Powders Limited
    Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    4b Christchurch House
    England
    06 apr 2016
    Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road
    Medway City Estate
    ME2 4FX Rochester
    4b Christchurch House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione03086477
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 giu 2008
    Consegnato il 18 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 18 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 nov 2003
    Consegnato il 14 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (Security Holder)
    Transazioni
    • 14 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 nov 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Matthew Dalton (Holdings) Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 gen 2000
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all book and other debts and the benefit of all policies of insurance and a floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 gen 1992
    Consegnato il 16 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plus patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0