AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02283524 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?
- Produzione di amidi e derivati dell'amido (10620) / Industrie manifatturiere
Dove si trova AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 4b Christchurch House Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester Kent England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Nagle come segretario in data 14 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Nagle come amministratore in data 14 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Douglas Arnold Corbishley come amministratore in data 13 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 mar 2016 | 7 pagine | AAMD | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 31 mar 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Kirby il 10 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 7 Monkswell Park Manse Lane Knaresborough North Yorkshire HG5 8NQ a 4B Christchurch House Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate Rochester Kent ME2 4FX in data 26 lug 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Malcolm Terry come amministratore in data 18 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Nagle come segretario in data 18 gen 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Malcolm Terry come segretario in data 18 gen 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Neil Maurice Dyer come amministratore in data 30 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRBY, Michael James | Amministratore | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House Kent England | United Kingdom | British | 49079440007 | |||||
| BLACKETT, Colin | Segretario | 2 Rowallane Gardens Ingleby Barwick TS17 0YQ Stockton On Tees Cleveland | British | 55782360001 | ||||||
| BROTHERTON, Colin Michael | Segretario | 30 Firs Drive HG2 9HB Harrogate Yorkshire | British | 2175870001 | ||||||
| CLARK, Carol Jane | Segretario | 36 Ellesborough Road Wendover HP22 6EL Aylesbury Buckinghamshire | British | 30876290002 | ||||||
| NAGLE, John | Segretario | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House Kent England | 204360410001 | |||||||
| NAGLE, John | Segretario | Lower Grange Newington OX10 7AA Wallingford Oxfordshire | British | 110378680001 | ||||||
| REID-RUTHERFORD, Brian Walter | Segretario | The Glebe Broad Way Uffington SN7 7QH Faringdon Oxfordshire | British | 46141050002 | ||||||
| TERRY, Christopher Malcolm | Segretario | Unit 7 Monkswell Park Manse Lane HG5 8NQ Knaresborough North Yorkshire | 184209270001 | |||||||
| WILFORD, Roy | Segretario | Hindlea Trigfa Estate LL72 8LL Moelfre Anglesey | British | 76263740001 | ||||||
| BEGY, Roger Bilton | Amministratore | Lindow Cottage 25 Main Street Greetham LE15 7NJ Oakham Leicestershire | England | British | 96584330001 | |||||
| BROTHERTON, Colin Michael | Amministratore | 30 Firs Drive HG2 9HB Harrogate Yorkshire | British | 2175870001 | ||||||
| CORBISHLEY, Douglas Arnold | Amministratore | Site 51 Comp 10 Rr \ 1 Okdnagon Falls VOH 1RO British Columbia Canada | Canada | Canadian | 84156620003 | |||||
| DALTON, James Matthew Percy | Amministratore | The Old Mistal Rigton Gates Farm North Rigton LS17 0DR Leeds | England | British | 22602880001 | |||||
| DUFFETT, William Harold | Amministratore | 6 Leigh Close Westbury Leigh BA13 3SX Westbury Wiltshire | British | 52510650001 | ||||||
| DYER, Neil Maurice | Amministratore | 7 Wakes Meadow Bunbury CW6 9SH Tarporley Cheshire | England | United Kingdom | 71140500001 | |||||
| FIRTH, Michael Roger | Amministratore | Lamb Hall Road Longwood HD3 3TH Huddersfield Lower Snow Lea Farm West Yorkshire | England | British | 134543140001 | |||||
| NAGLE, John | Amministratore | Lower Grange Newington OX10 7AA Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | 110378680001 | |||||
| TERRY, Christopher Malcolm, Mr. | Amministratore | Unit 7 Monkswell Park Manse Lane HG5 8NQ Knaresborough North Yorkshire | England | British | 60746700002 | |||||
| WILFORD, Roy | Amministratore | Hindlea Trigfa Estate LL72 8LL Moelfre Anglesey | British | 76263740001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty Powders Limited | 06 apr 2016 | Beaufort Court, Sir Thomas Longley Road Medway City Estate ME2 4FX Rochester 4b Christchurch House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
AGGLOMERATION TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 12 giu 2008 Consegnato il 18 giu 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 10 nov 2003 Consegnato il 14 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 nov 2003 Consegnato il 12 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 gen 2000 Consegnato il 27 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge all book and other debts and the benefit of all policies of insurance and a floating charge. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 15 gen 1992 Consegnato il 16 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plus patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0