EVEREST HOME COVER LIMITED

EVEREST HOME COVER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEVEREST HOME COVER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02285034
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EVEREST HOME COVER LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EVEREST HOME COVER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EVEREST HOME COVER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EVEREST LEGACY LIMITED21 apr 199921 apr 1999
    CARADON EVEREST LEGACY LIMITED09 dic 199209 dic 1992
    CARADON EVEREST HERITAGE LIMITED20 nov 199220 nov 1992
    MB LIMITED25 apr 198925 apr 1989
    CMB PACKAGING (U.K.) LIMITED17 nov 198817 nov 1988
    ALNERY NO. 772 LIMITED08 ago 198808 ago 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di EVEREST HOME COVER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EVEREST HOME COVER LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per EVEREST HOME COVER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2013

    Stato del capitale al 01 lug 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ott 2012 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Varie

    Auditors resignations
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 ott 2011

    14 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    6 pagineMEM/ARTS

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Simon Jarman come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    11 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Richard Meirion Warwick-Saunders come segretario

    1 pagineAP03

    legacy

    13 pagineMG01

    legacy

    11 pagineMG01

    Nomina di Mr Peter John Williamson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Nick Ian Burgess Sanders come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Hopley come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EVEREST HOME COVER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    168813430001
    JORDAN, Alan James
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandIrish150320720001
    SANDERS, Nicholas Ian Burgess
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish83283880002
    WILLIAMSON, Peter John
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish168016150001
    BHOWMIK, Chandan Kanti
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    Segretario
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    British3752320001
    BHOWMIK, Chandan Kanti
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    Segretario
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    British3752320001
    CAMERON, Ewen
    Oakfield House Station Road
    RG10 8EU Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    Oakfield House Station Road
    RG10 8EU Wargrave
    Berkshire
    British2421530001
    FAWCETT, Christopher Stephen
    15 Blenheim Court
    Stanmore Road Kew
    TW9 2DA Richmond
    Surrey
    Segretario
    15 Blenheim Court
    Stanmore Road Kew
    TW9 2DA Richmond
    Surrey
    British81019930001
    JARMAN, Simon James
    1 Swanley Bar Lane
    EN6 1NN Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Swanley Bar Lane
    EN6 1NN Potters Bar
    Hertfordshire
    British65100170002
    SMETHURST, Edward Gerald
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    United Kingdom
    British86741880002
    BHOWMIK, Chandan Kanti
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    British3752320001
    BHOWMIK, Chandan Kanti
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    British3752320001
    CAMERON, Ewen
    Oakfield House Station Road
    RG10 8EU Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    Oakfield House Station Road
    RG10 8EU Wargrave
    Berkshire
    British2421530001
    EADY, Roy Thomas
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    EnglandBritish3078230001
    FAWCETT, Christopher Stephen
    15 Blenheim Court
    Stanmore Road Kew
    TW9 2DA Richmond
    Surrey
    Amministratore
    15 Blenheim Court
    Stanmore Road Kew
    TW9 2DA Richmond
    Surrey
    British81019930001
    HOLLAND, Anthony Edward
    6 Brooklyn Drive
    Emmer Green
    RG4 8SS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    6 Brooklyn Drive
    Emmer Green
    RG4 8SS Reading
    Berkshire
    EnglandBritish38110900001
    HOPLEY, Mark Simon Griffith
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritish105670800002
    JARMAN, Simon James
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish65100170002
    MAHONEY, Kevin David
    Field House
    Rook Wood Way
    HP16 0DF Great Missenden
    Bucks
    Amministratore
    Field House
    Rook Wood Way
    HP16 0DF Great Missenden
    Bucks
    British63238350001
    MONEY, Wayne Adrian
    28 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Amministratore
    28 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    EnglandBritish8746410001
    MONKS, Terence John
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    British80344460001
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Amministratore
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    TILMAN, David Ward
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish81215590001
    WALKER, Timothy
    Sandhurst Farm
    Clayhill Road, Lamberhurst
    TN3 8AX Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Sandhurst Farm
    Clayhill Road, Lamberhurst
    TN3 8AX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish64603310001
    WINSTONE, Robert James
    Down Farmhouse The Down
    TN3 8HA Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Down Farmhouse The Down
    TN3 8HA Tunbridge Wells
    Kent
    British12687420004

    EVEREST HOME COVER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 giu 2012
    Consegnato il 28 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited
    Transazioni
    • 28 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 apr 2012
    Consegnato il 30 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Fund LP
    Transazioni
    • 30 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2012
    Consegnato il 11 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 08 nov 2011
    Consegnato il 21 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for Itself and Others
    Transazioni
    • 21 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 08 nov 2011
    Consegnato il 21 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any one or more of the principals or the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 17 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of evendate.
    Brevi particolari
    £8,685.00 or such other sums from time to time deposited with the mortgagee pursuant to the terms of the deed.
    Persone aventi diritto
    • Regent Gate Developments Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0