LEE BARON COMMERCIAL LIMITED

LEE BARON COMMERCIAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEE BARON COMMERCIAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02285494
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEE BARON COMMERCIAL LIMITED?

    • Attività di agenzie immobiliari (68310) / Attività immobiliari
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova LEE BARON COMMERCIAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Burlington House
    1075 Finchley Road
    NW11 0PU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEE BARON COMMERCIAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OVALBOURNE LIMITED09 ago 198809 ago 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEE BARON COMMERCIAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per LEE BARON COMMERCIAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2012

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert James Lewis il 04 gen 2013

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2012

    Stato del capitale al 03 set 2012

    • Capitale: GBP 110
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2011 al 31 lug 2011

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Abraham Landy come amministratore

    2 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Tebbutt il 23 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Christopher Jones il 23 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Steve Adeleye il 23 nov 2010

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Steve Adeleye il 23 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Robert James Lewis il 23 nov 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Susan Noe come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ian Felice come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Marsden come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    7 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di LEE BARON COMMERCIAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ADELEYE, Steve
    Chorister Crescent
    Hoo
    ME3 9FB Rochester
    Casa Feliz
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Chorister Crescent
    Hoo
    ME3 9FB Rochester
    Casa Feliz
    Kent
    United Kingdom
    British139246210001
    ADELEYE, Steve
    Chorister Crescent
    Hoo
    ME3 9FB Rochester
    Casa Feliz
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Chorister Crescent
    Hoo
    ME3 9FB Rochester
    Casa Feliz
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish139246210002
    DEMBITZ, John Andrew
    7 Camelot Close
    SW19 7EA London
    Amministratore
    7 Camelot Close
    SW19 7EA London
    EnglandBritish15837270003
    HARDING, Simon Jeremy
    23 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    23 Woodlands Way
    KT21 1LH Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish54047470002
    JACKSON, John
    47 Bridge Lane
    NW11 0ED London
    Amministratore
    47 Bridge Lane
    NW11 0ED London
    EnglandBritish39890290001
    JONES, Ian Christopher
    29 Onslow Gardens
    N10 3JT London
    Flat B
    United Kingdom
    Amministratore
    29 Onslow Gardens
    N10 3JT London
    Flat B
    United Kingdom
    United KingdomBritish80104510001
    LEWIS, Robert James
    Sheen Gate Gardens
    East Sheen
    SW14 7NF London
    10b
    Amministratore
    Sheen Gate Gardens
    East Sheen
    SW14 7NF London
    10b
    United KingdomBritish46117260003
    TEBBUTT, Paul
    Grove Avenue
    N3 1QJ London
    29
    United Kingdom
    Amministratore
    Grove Avenue
    N3 1QJ London
    29
    United Kingdom
    United KingdomBritish104103130002
    WHAYMAN, Carl Peter
    The Willows
    21 Fairgreen
    EN4 0QS Cockfosters
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Willows
    21 Fairgreen
    EN4 0QS Cockfosters
    Hertfordshire
    United KingdomBritish32035880003
    JACKSON, John
    47 Bridge Lane
    NW11 0ED London
    Segretario
    47 Bridge Lane
    NW11 0ED London
    British39890290001
    LAW, Charles Howard
    Oak Bank
    London Road
    HP7 9DP East Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    Oak Bank
    London Road
    HP7 9DP East Amersham
    Buckinghamshire
    British155846650001
    NOE, Susan Debra
    12 Grosvenor Gardens
    NW11 0HG London
    Segretario
    12 Grosvenor Gardens
    NW11 0HG London
    British13760310001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Segretario
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    BENJAMIN, Stephen Edward
    9 Crescent Road
    Wimbledon
    SW20 8EX London
    Amministratore
    9 Crescent Road
    Wimbledon
    SW20 8EX London
    British25407380001
    COXON, Iain
    29 The Elms
    SG13 7UY Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    29 The Elms
    SG13 7UY Hertford
    Hertfordshire
    British43807300001
    CUNNINGHAM, Paul Anthony
    29 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FD Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    29 Pewterspear Green Road
    Appleton
    WA4 5FD Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish79718570001
    DENNIS, Susan Haig
    37 Ashley Lane
    Hendon
    NW4 1HH London
    Amministratore
    37 Ashley Lane
    Hendon
    NW4 1HH London
    British16528520002
    EDWARDS, Simon Conrad
    31 Ingreway
    RM3 0BN Harold Park
    Essex
    Amministratore
    31 Ingreway
    RM3 0BN Harold Park
    Essex
    British78479150001
    FELICE, Ian Paul
    307 Watergardens
    FOREIGN Gibraltar
    Amministratore
    307 Watergardens
    FOREIGN Gibraltar
    GibraltarBritish109922780001
    LANDY, Abraham David
    14 Prothero Gardens
    Hendon
    NW4 3SL London
    Amministratore
    14 Prothero Gardens
    Hendon
    NW4 3SL London
    EnglandBritish30486300002
    LAW, Charles Howard
    Oak Bank
    London Road
    HP7 9DP East Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oak Bank
    London Road
    HP7 9DP East Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish155846650001
    MARSDEN, Stephen Christopher
    211 Watergardens
    FOREIGN Gibraltar
    Amministratore
    211 Watergardens
    FOREIGN Gibraltar
    British109922690001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    Amministratore
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    NOE, Leopold
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    EnglandBritish64965010001
    ROBERTS, David Ian
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    British38276960001
    SASSOON, David Elisha
    68 Bell Lane
    NW4 2AE London
    Amministratore
    68 Bell Lane
    NW4 2AE London
    British41634040001
    SHARP, Rodney Alfred
    4 Deepings Close
    SG3 6BW Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Deepings Close
    SG3 6BW Knebworth
    Hertfordshire
    British38973230001
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    Amministratore
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SMITH, Ivor
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    Amministratore
    1 Bridge Lane
    NW11 0EA London
    British21120940001
    SMITH, Patrick John
    Oakdene
    Hawthorn Lane, Farnham Common
    SL2 3SW Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Oakdene
    Hawthorn Lane, Farnham Common
    SL2 3SW Slough
    Berkshire
    EnglandBritish127384110001

    LEE BARON COMMERCIAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Account charge
    Creato il 24 giu 1996
    Consegnato il 27 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement and the security documents
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in the account specifically designated lee baron commercial limited client account at the royal bank of scotland PLC acc/no:- 20135338 (or such other accounts or accounts as may be established in substitution therefor or in addition thereto) and the deposit being the amounrt standing to the credit of the account and all rights in respect of. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party legal charge
    Creato il 28 ott 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from vasella limited and/or vasella holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 8 baltic street finsbury l/b of islington t/n 49211. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of life policy
    Creato il 28 ott 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement, related security or related security document (as defined) or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assignment to the bank of the policy of life assurance dated 1/4/93 numbered 10773-102-das. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 ott 1993
    Consegnato il 10 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings known as 8 baltic street finsbury l/borough of islington t/n 49211. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 10 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 18 dic 1989
    Consegnato il 28 dic 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 28 dic 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0