S.G. INDUSTRIES LIMITED

S.G. INDUSTRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàS.G. INDUSTRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02290541
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di S.G. INDUSTRIES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova S.G. INDUSTRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di S.G. INDUSTRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEGIBUS 1294 LIMITED26 ago 198826 ago 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di S.G. INDUSTRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per S.G. INDUSTRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 apr 2013

    6 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 apr 2012

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 22 set 2011

    • Capitale: GBP 152,058.31
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Capital redemption reserve canceeld 16/09/2011
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Stuart Morriss il 08 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Michael Hayhurst il 08 mag 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Lloyd Kynaston il 08 mag 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di S.G. INDUSTRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAYHURST, Michael
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Segretario
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    BritishChartered Accountant15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritishDirector10529040001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Harlescott Lane
    SY1 3AS Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritishDirector11643310001
    AITKEN, Robert Ferguson
    Mile End
    Lower Assendon
    RG9 6AL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    Mile End
    Lower Assendon
    RG9 6AL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British7169900001
    CRIBB, Nicholas Stephen
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    16 Glebe Road
    B91 2LX Solihull
    West Midlands
    British100811140001
    DAVIES, John Graeme
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Airlie
    Roberts Lane, Chalfont St. Peter
    SL9 0QR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary72253030004
    SMITH, Alastair Moray
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    Segretario
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    BritishDirector9819210001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Segretario
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Secretary36008490001
    AITKEN, Robert Ferguson
    Mile End
    Lower Assendon
    RG9 6AL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mile End
    Lower Assendon
    RG9 6AL Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director7169900001
    BOSS, Edward William
    14 Dunnock Way
    RG10 8LR Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    14 Dunnock Way
    RG10 8LR Wargrave
    Berkshire
    BritishCompany Director46425610001
    CLEMENTS, Alan William
    Wildbriar
    41 Shirley Hills Road
    CR0 7HQ Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Wildbriar
    41 Shirley Hills Road
    CR0 7HQ Croydon
    Surrey
    BritishCompany Director5575140001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector72559760001
    GONSZOR, Charles Paterson
    Triton Court
    14 Finsbury Square
    London
    Amministratore
    Triton Court
    14 Finsbury Square
    London
    BritishCompany Director39909820002
    HOBBS, Ronald Robert Collins
    Blue Hills
    Yalding Hill
    ME18 6AN Yalding
    Kent
    Amministratore
    Blue Hills
    Yalding Hill
    ME18 6AN Yalding
    Kent
    BritishVenture Capital9643470002
    HUGHES, Mark Leonard William
    Pippin Lodge Church Road
    Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Pippin Lodge Church Road
    Snitterfield
    CV37 0LF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director51202520001
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    BritishDirector131639570001
    MACMILLAN, Keith, Professor
    Remenham House Remenham Hill
    Remenham
    RG9 3EP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Remenham House Remenham Hill
    Remenham
    RG9 3EP Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishCompany Director15116210001
    POYSER, Timothy Keith
    Clere Wood House
    Andover Road Highclere
    RG20 9RE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Clere Wood House
    Andover Road Highclere
    RG20 9RE Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director17249190002
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    Amministratore
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector40953790002
    SMITH, Alastair Moray
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Ryecroft Stafford Road
    Great Bridgeford
    ST18 9SQ Stafford
    Staffordshire
    BritishDirector9819210001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector1600540001
    WILEY, William Struan Ferguson
    Old Rectory
    Withcall
    LN11 9RL Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Old Rectory
    Withcall
    LN11 9RL Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director43643920001
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Secretary36008490001

    S.G. INDUSTRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A hong kong law governed supplemental debenture dated 24TH august 1999
    Creato il 24 ago 1999
    Consegnato il 10 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The secured obligations due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee arising under the debenture as amended
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A singapore law governed supplemental debenture dated 24TH august 1999
    Creato il 24 ago 1999
    Consegnato il 10 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The secured obligations due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee arising under the debenture as amended
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent)
    Transazioni
    • 10 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture to target group debenture
    Creato il 24 ago 1999
    Consegnato il 10 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The secured obligations due or to become due from each charging entity to the chargee under or pursuant to the debenture (as amended)
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property (other than the heritable property in scotland) owned by the company or in which the company has an interest at the date of the charge all its other assets and undertakings (and all rights in respect thereof). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture) from Time to Time
    Transazioni
    • 10 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 12 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 12 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite (singapore law governed) guarantee and debenture
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 12 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred as from time to time varies or extended under or pursuant to the target group debenture (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 12 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite (hong kong law governed) guarantee and debenture
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 12 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and all obligations due or to become due from the company to the chargee acting as security agent for the finance parties (as defined) or any of them pursuant to the facilities agreement including without limitation all monies obligations and liabilities due owing or incurred as from time to time varies or extended under or pursuant to the target group debenture (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 12 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ago 1995
    Consegnato il 01 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the other secured parties (as defined therein) under the terms of any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    F/H land at lakeside road, colnbrook, iver, buckinghamshire t/no. BM66230. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 07 apr 1995
    Consegnato il 26 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    And for varying the terms of the debenture dated 3RD december 1991
    Brevi particolari
    All that property listed and more particularly described in the debenture dated 3 december 1991.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Full mortgage debenture
    Creato il 03 dic 1991
    Consegnato il 20 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the subordinated loan agreement the existing subordinated loan agreement and this debenture as amended by a supplemental deed dated 19/12/91
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 gen 1989
    Consegnato il 23 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself, the arranger and the lenders (as defined in the senior credit agreement dated 6/1/89) under the terms of the finance documents and the charge
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    S.G. INDUSTRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2013Data di scioglimento
    24 apr 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0