FILE-IT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFILE-IT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02291975
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FILE-IT LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova FILE-IT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    K House Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FILE-IT LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per FILE-IT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 022919750013 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022919750015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022919750014 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022919750011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022919750012 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 022919750010 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Robert Rolph Baldrey come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Haworth come amministratore in data 13 apr 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 26 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mar 2016

    Stato del capitale al 15 mar 2016

    • Capitale: GBP 40
    SH01

    Cessazione della carica di Andrew Ian Craig come amministratore in data 12 feb 2016

    1 pagineTM01

    legacy

    50 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Iscrizione di un'ipoteca

    pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    20 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 022919750006, creata il 24 apr 2015

    69 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022919750005, creata il 24 apr 2015

    63 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022919750004, creata il 24 apr 2015

    76 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022919750010, creata il 24 apr 2015

    44 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 022919750011, creata il 24 apr 2015

    41 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di FILE-IT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MENDELSOHN, Lorna
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Segretario
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    194464280001
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    Amministratore
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director155681500001
    HAWORTH, Stephen
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    Amministratore
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Ceo155690570001
    CARROLL, David
    3 Stanbrook Close
    Manton
    SN8 4HY Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    3 Stanbrook Close
    Manton
    SN8 4HY Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector3797940002
    DAVIES, Ashley Mark
    21 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    Segretario
    21 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    British88706840001
    HUNTLEY, Paul
    Park View Foghampshire Lane
    Trudoxhill
    BA11 5DG Frome
    Somerset
    Segretario
    Park View Foghampshire Lane
    Trudoxhill
    BA11 5DG Frome
    Somerset
    British62415060001
    RODWELL, Debra Jane Clare
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Saint Crispins House
    Norfolk
    Segretario
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Saint Crispins House
    Norfolk
    British125214030001
    BALDREY, Robert Rolph
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    Amministratore
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo78328360005
    BARRY, Mark Anthony
    25 Knowle Road
    Totterdown
    BS4 2EB Bristol
    Amministratore
    25 Knowle Road
    Totterdown
    BS4 2EB Bristol
    United KingdomBritishArea Director57454320001
    CARROLL, David
    3 Stanbrook Close
    Manton
    SN8 4HY Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Stanbrook Close
    Manton
    SN8 4HY Marlborough
    Wiltshire
    BritishDirector3797940002
    CRAIG, Andrew Ian
    9 Kings Road
    SO22 5QB Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    9 Kings Road
    SO22 5QB Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishDirector52494990002
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Saint Crispins House
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Saint Crispins House
    Norfolk
    EnglandBritishFinance Director130923460003
    DAVIES, Ashley Mark
    21 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    21 Dymott Square
    Hilperton
    BA14 7RW Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritishManaging Director88706840001
    GREENE, Paul Robert
    1 Blacksmiths Lane
    Kelston
    BA1 9AH Bath
    Amministratore
    1 Blacksmiths Lane
    Kelston
    BA1 9AH Bath
    BritishSales Director11136340003
    HUNTLEY, Paul
    Park View Foghampshire Lane
    Trudoxhill
    BA11 5DG Frome
    Somerset
    Amministratore
    Park View Foghampshire Lane
    Trudoxhill
    BA11 5DG Frome
    Somerset
    BritishAccountant62415060001
    MOATE, Simon Richard
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Saint Crispins House
    Norfolk
    Amministratore
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Saint Crispins House
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive126182400002
    WHITTAL, Richard Marcus
    Parsonage Farm House
    Church Road
    SN4 0BZ Wanborough
    Amministratore
    Parsonage Farm House
    Church Road
    SN4 0BZ Wanborough
    EnglandBritishSales59810400002

    FILE-IT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H property k/a 16A crawfordsburn road newtownwards county down.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Cpacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 30 apr 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 30 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 29 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 29 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2015
    Consegnato il 28 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Mortgage deed
    Creato il 25 giu 2001
    Consegnato il 05 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as unit,e goodwood close white horse business park,. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 26 ago 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a richmond house goodwood close white horse business park trowbridge wilts. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1988
    Consegnato il 19 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    & heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0