COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED

COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02295319
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45200) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Crowthorne House
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Berkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VEHICLE DISPOSAL LIMITED08 mar 199008 mar 1990
    AXBRIDGE INVESTMENTS LIMITED31 gen 198931 gen 1989
    HACKREMCO (NO.423) LIMITED13 set 198813 set 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Robert William Guy Whitrow come amministratore in data 02 ott 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roger Graham Partridge come amministratore in data 28 set 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ago 2012

    Stato del capitale al 21 ago 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Crowthorne House Nine Mile Road Wokingham Berkshire RG40 3GA in data 30 mar 2012

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    11 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 17 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Nomina di Robert William Guy Whitrow come amministratore

    3 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dettagli del direttore cambiati per Roger Graham Partridge il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per David Alan Bird il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per David Alan Bird il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Roderick Neil Graham il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIRD, David Alan
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    British89738470001
    BIRD, David Alan
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89738470001
    GRAHAM, Roderick Neil
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish51466570002
    DEAN, Julian Mark
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    Segretario
    23 Marden Way
    GU31 4PW Petersfield
    Hampshire
    British47136600002
    MCCALL, William
    Arngibbon House
    FK8 3ES Kippen
    Stirlingshire
    Segretario
    Arngibbon House
    FK8 3ES Kippen
    Stirlingshire
    British39902920003
    MORRISON, Audrey
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    Segretario
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    British44972470001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British7680750001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British7680750001
    SCHRAGER VON ALTISHOFEN, Nicola Jane
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    Oliver House Stud
    Ched Glow
    SN16 9EZ Malmesbury
    Wiltshire
    British110050670001
    STALKER, Christopher David
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    Segretario
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    British75389440001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Segretario
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    British45988970001
    JOHNSTON, Anthony Maurice
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    Amministratore
    14 Agars Place
    Datchet
    SL3 9AH Berkshire
    EnglandBritish91243020001
    MCCOMB, Robert Wilson
    3 Firs Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LY London
    Amministratore
    3 Firs Avenue
    Muswell Hill
    N10 3LY London
    United KingdomBritish13929280001
    MCRAE, Michael John Standing
    The Berries
    Westmill
    SG9 9LL Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Berries
    Westmill
    SG9 9LL Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish52779060001
    MORROW, John David
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    281 Greys Road
    RG9 1QT Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish7680750001
    PARTRIDGE, Roger Graham
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    BerkshireBritish84959730003
    STALKER, Christopher David
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Nightingale Cottage
    4 Popes Lane
    SL6 9NY Cookham Dean
    Berkshire
    EngalndBritish75389440001
    STEAD, Nigel Cleator
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Northend
    Timble
    LS21 2NN Otley
    West Yorkshire
    EnglandBritish47582470001
    STEPHENS, Nigel Charles
    Forest House 61 Chertsey Road
    GU20 6HE Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Forest House 61 Chertsey Road
    GU20 6HE Windlesham
    Surrey
    British1680570001
    VOSS, David Anthony Henry
    Calleva
    Harpsden Way
    RG9 1NL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Calleva
    Harpsden Way
    RG9 1NL Henley On Thames
    Oxfordshire
    British6551300002
    WHITE, Andrew John
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    British8107360001
    WHITROW, Robert William Guy
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Nine Mile Ride
    RG40 3GA Wokingham
    Crowthorne House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish83349560001
    YOUNG, Lorraine Elizabeth
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    3 Vaughan Avenue
    TN10 4EB Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish45988970001

    COUNTRYWIDE VEHICLE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 gen 2011
    Consegnato il 07 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander Asset Finance PLC (Creditor)
    Transazioni
    • 07 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 29 ago 2008
    Consegnato il 05 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and each other obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H interest in the property k/a office suites 1 and 2 first floor guildgate house high street crowthorne berkshire t/no BK261879,l/h interest in the property k/a regal house station road marlow t/no BM245030,l/h interest in the property k/a part second floor crowthorne house nine mile ride crowthorne t/no BK394247 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 05 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent Trustee for the Finance Parties (Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 dic 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0