OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED

OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02296286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Whittington Hall
    Whittington Road, Whittington
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    B.E.S.P. THREE LIMITED14 set 198814 set 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 dic 2018

    • Capitale: GBP 0.03
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium 11/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    1 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2016

    Stato del capitale al 28 apr 2016

    • Capitale: GBP 534,741.33
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2015

    Stato del capitale al 05 mag 2015

    • Capitale: GBP 534,741.33
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Martin Barker il 18 lug 2014

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mag 2014

    Stato del capitale al 15 mag 2014

    • Capitale: GBP 534,741.33
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    1 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Andrew Martin Barker come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PEMBERSTONE (SECRETARIES) LIMITED
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Segretario
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04002731
    77906620001
    ANNETTS, David Charles
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81373880001
    BARKER, Andrew Martin
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Amministratore
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United KingdomBritish149813130009
    REYNOLDS, Mark Andrew
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    Amministratore
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United KingdomBritish41446640003
    ANNETTS, David Charles
    The Snead
    Pensax
    WR6 6AG Abberley
    Worcestershire
    Segretario
    The Snead
    Pensax
    WR6 6AG Abberley
    Worcestershire
    British81373880001
    WILCOX, Margaret Alice
    39 Edgeway Road
    OX3 Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    39 Edgeway Road
    OX3 Oxford
    Oxfordshire
    British13930930001
    CIM MANAGEMENT LIMITED
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    Whittington Hall
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Worcestershire
    70618260001
    AGULNIK, Elisabeth Jean
    Hill House
    Burgage Lane
    NG25 0GR Southwell
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Hill House
    Burgage Lane
    NG25 0GR Southwell
    Nottinghamshire
    British126081990001
    ANNETTS, David Charles
    The Snead
    Pensax
    WR6 6AG Abberley
    Worcestershire
    Amministratore
    The Snead
    Pensax
    WR6 6AG Abberley
    Worcestershire
    United KingdomBritish81373880001
    BARKER, Andrew Martin
    Upper Birch Farm
    Shatterford
    DY12 1TR Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    Upper Birch Farm
    Shatterford
    DY12 1TR Bewdley
    Worcestershire
    British54622310001
    BLANCHARD, Ian
    124 High Street
    Chalgrove
    OX44 7ST Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    124 High Street
    Chalgrove
    OX44 7ST Oxford
    Oxfordshire
    British8977940001
    COX, Charles Fahie Mckay
    Home Farm
    Duddington
    PE9 3QE Stamford
    Lincs
    Amministratore
    Home Farm
    Duddington
    PE9 3QE Stamford
    Lincs
    British5728850001
    GLUCKLICH, Thomas Charles
    Mill House
    Mill Lane
    ME9 7TD Hartlip
    Kent
    Amministratore
    Mill House
    Mill Lane
    ME9 7TD Hartlip
    Kent
    British35568290002
    HOLDEN, Peter James
    Manton Corner Bath Road
    SN8 1NR Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Manton Corner Bath Road
    SN8 1NR Marlborough
    Wiltshire
    British7973520001
    MILNE, Reginald Edward
    The Manor House
    Horspath
    OX33 1RU Oxford
    Amministratore
    The Manor House
    Horspath
    OX33 1RU Oxford
    British4579080001
    PEMBERSTONE (DIRECTORS) LIMITED
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    Worcestershire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04234888
    82038280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pgl (201) Limited
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    England
    06 apr 2016
    Whittington Road
    WR5 2ZX Worcester
    Whittington Hall
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione2531045
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    OXFORD RESIDENTIAL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 giu 1999
    Consegnato il 21 giu 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 21 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 1999
    Consegnato il 21 giu 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999
    Brevi particolari
    The property known as DY221558 & DY218907 for further property details see ch microfiche. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 21 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 giu 1999
    Consegnato il 11 giu 1999
    In corso
    Importo garantito
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 11 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 08 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 mag 1997
    Consegnato il 17 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as dunston close long eaton nottinghamshire title number DY218907 and DY221558. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mag 1997
    Consegnato il 04 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a devere court 21 clopton road stratford upon avon.t/no.WK315821. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 set 1995
    Consegnato il 05 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-51 gipsy lane headington oxforshire t/n-ON3850. L/h-19 dudley court and parking space 8 roger street oxfordshire t/n-ON33019. F/h-142 dene road headington oxfordshire t/n-ON41529. (For full details of property charged see continuation sheet attached to the form 395). and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 31 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H flat 4, 61 alexandra road reading berks. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 31 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H flat 5, 61 alexandra court reading berks. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 31 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H flat 3 61 alexandra road reading berks. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1993
    Consegnato il 31 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a flat 6, 61 alexandra road reading berks. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    40 hugh allen crescent, marston oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    142 rene road headington oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    27 hugh allen crescent, marston, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    48 granville court, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    75 hugh allen crescent, marston oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16 ock mill, abington, oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    51 gupsy lane, headington, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    58 hugh allin crescent, marston, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19 dudley court, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    16 hayes close, marston, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    60 butler close, oxford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6 ock mill, abingdon oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 07 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    12 ock mill, abingdon oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0