THE UK CHANNEL LIMITED

THE UK CHANNEL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE UK CHANNEL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02301363
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE UK CHANNEL LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova THE UK CHANNEL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The London Television Centre
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE UK CHANNEL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE HOME SERVICE CHANNEL LIMITED20 lug 198920 lug 1989
    MANI LIMITED30 set 198830 set 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE UK CHANNEL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per THE UK CHANNEL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 nov 2009

    Stato del capitale al 24 nov 2009

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Eleanor Kate Irving il 16 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Helen Jane Tautz il 16 ott 2009

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF in data 12 ott 2009

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    2 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Section 175(5)a 22/09/2008
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    2 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    2 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di THE UK CHANNEL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IRVING, Eleanor Kate
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish79177030002
    TAUTZ, Helen Jane
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish37564540001
    ABDOO, David
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    Segretario
    78 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NN London
    British40437090001
    HOWLE, Michael Anthony
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    Segretario
    46 Dowlans Road
    KT23 4LE Great Bookham
    Surrey
    British32460850001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Segretario
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Segretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    ANCLIFF, Christopher John
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    Amministratore
    121 Chestnut Grove
    SW12 8JH London
    British52876050001
    BIRDSEYE, Sarah Elizabeth
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    Amministratore
    4 Bowood Road
    SW11 6PE London
    British69659880002
    BUGGY, Alan Richard
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    Amministratore
    927 Westover Road
    Stamford Connecticut
    FOREIGN
    Usa
    American4860890001
    CONSTANT, Richard Michael
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    Amministratore
    6 Balniel Gate
    SW1V 3SD London
    United KingdomBritish43836310003
    CRESSWELL, John
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Rosslyn House 8 Park Road
    SO22 6AA Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish39795820003
    DILNOTT-COOPER, Rupert Michael Walter James
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    Amministratore
    23 Glenmore Road
    NW3 4BY London
    EnglandBritish52448400001
    FORREST, Ian Mcclure
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    Amministratore
    Brewhurst House
    Brewhurst
    RH14 0RJ Loxwood
    West Sussex
    British2327400003
    GOROG, William Christopher
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    Amministratore
    9044 Melrose Avenue
    FOREIGN Los Angeles
    90069
    Usa
    American96074620002
    HAIMOVITZ, Jules
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    Amministratore
    10551 Wilshire Boulevard
    90024 Los Angeles
    California
    U.S.A.
    American43075680001
    HUTCHINGS, David George
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    Amministratore
    Crepping Hall
    CO6 2AL Wakes Colne
    Essex
    British10085500002
    JACQUES, John Douglas
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    White Gates 81 East Lane
    West Horsley
    KT24 6LR Leatherhead
    Surrey
    British3170310001
    JOHNSON, David
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    Amministratore
    50 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1BA Brentwood
    Essex
    EnglandBritish76706450001
    LUCAS, Anthony Ronald
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    Amministratore
    Flat 12 Beatrix House
    208 Old Beatrix Road
    SW5 0BP London
    British30771870001
    MARRINAN, James
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    Amministratore
    206815 Hot Springs Place
    Agoura Hills California Ca91301
    FOREIGN
    Usa
    American17905570001
    MEDLICOTT, William Jonathan
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    Amministratore
    Wild Boars
    Monteswood Lane
    RH17 7NS Horsted Keynes
    West Sussex
    EnglandEnglish44636500002
    POHL, Henry Theodore
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    227 Hanworth Road
    TW12 3EF Hampton
    Middlesex
    British32450180001
    SANITSKY, Robert
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Amministratore
    9100 Wilshire Boulevard
    Suite 600
    90212 Beverley Hills
    Los Angeles California
    Usa
    Usa53433450001
    SMITH, Kathryn
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    Amministratore
    9 Hanover Steps
    Saint Georges Fields
    W2 2YG London
    British77161950001
    TILL, Stewart Myles
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    Barrymore 6 High Street
    RG10 8HY Wargrave
    Berkshire
    British24204890001
    WILLIAMS, Lucinda Mary
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    34 Helena Road
    SL4 1JN Windsor
    Berkshire
    British55121890001

    THE UK CHANNEL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 06 feb 1991
    Consegnato il 14 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreements dated 5/2/91 and all other facility documents on defined
    Brevi particolari
    (See doc M132 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for and on Behalf of Trelfand the Banks
    Transazioni
    • 14 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amanded and restated copyright collaterol assignment agreement
    Creato il 05 feb 1991
    Consegnato il 14 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in the " collaferal" (see form 395 ref M108 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transazioni
    • 14 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trademark security agreement
    Creato il 05 feb 1991
    Consegnato il 14 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 395 - ref M124 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transazioni
    • 14 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Us security agreement (created by the home service channel limited now k/a the U.K. channel limited)
    Creato il 05 feb 1991
    Consegnato il 14 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 396- ref m 116 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC(As Agent for the Benefit of the Beneficiaries as Defined)
    Transazioni
    • 14 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 gen 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0