THE UK CHANNEL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THE UK CHANNEL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02301363 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE UK CHANNEL LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova THE UK CHANNEL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The London Television Centre Upper Ground SE1 9LT London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE UK CHANNEL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE HOME SERVICE CHANNEL LIMITED | 20 lug 1989 | 20 lug 1989 |
| MANI LIMITED | 30 set 1988 | 30 set 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE UK CHANNEL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2008 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE UK CHANNEL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Eleanor Kate Irving il 16 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Helen Jane Tautz il 16 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 200 Grays Inn Road London WC1X 8HF in data 12 ott 2009 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 8 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2006 | 2 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di THE UK CHANNEL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRVING, Eleanor Kate | Amministratore | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 79177030002 | |||||
| TAUTZ, Helen Jane | Amministratore | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 37564540001 | |||||
| ABDOO, David | Segretario | 78 Airedale Avenue Chiswick W4 2NN London | British | 40437090001 | ||||||
| HOWLE, Michael Anthony | Segretario | 46 Dowlans Road KT23 4LE Great Bookham Surrey | British | 32460850001 | ||||||
| LUCAS, Anthony Ronald | Segretario | Flat 12 Beatrix House 208 Old Beatrix Road SW5 0BP London | British | 30771870001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Segretario | 30 South Crescent Prittlewell SS2 6TA Southend On Sea Essex | British | 37564540001 | ||||||
| ANCLIFF, Christopher John | Amministratore | 121 Chestnut Grove SW12 8JH London | British | 52876050001 | ||||||
| BIRDSEYE, Sarah Elizabeth | Amministratore | 4 Bowood Road SW11 6PE London | British | 69659880002 | ||||||
| BUGGY, Alan Richard | Amministratore | 927 Westover Road Stamford Connecticut FOREIGN Usa | American | 4860890001 | ||||||
| CONSTANT, Richard Michael | Amministratore | 6 Balniel Gate SW1V 3SD London | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| CRESSWELL, John | Amministratore | Rosslyn House 8 Park Road SO22 6AA Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 39795820003 | |||||
| DILNOTT-COOPER, Rupert Michael Walter James | Amministratore | 23 Glenmore Road NW3 4BY London | England | British | 52448400001 | |||||
| FORREST, Ian Mcclure | Amministratore | Brewhurst House Brewhurst RH14 0RJ Loxwood West Sussex | British | 2327400003 | ||||||
| GOROG, William Christopher | Amministratore | 9044 Melrose Avenue FOREIGN Los Angeles 90069 Usa | American | 96074620002 | ||||||
| HAIMOVITZ, Jules | Amministratore | 10551 Wilshire Boulevard 90024 Los Angeles California U.S.A. | American | 43075680001 | ||||||
| HUTCHINGS, David George | Amministratore | Crepping Hall CO6 2AL Wakes Colne Essex | British | 10085500002 | ||||||
| JACQUES, John Douglas | Amministratore | White Gates 81 East Lane West Horsley KT24 6LR Leatherhead Surrey | British | 3170310001 | ||||||
| JOHNSON, David | Amministratore | 50 Rayleigh Road Hutton CM13 1BA Brentwood Essex | England | British | 76706450001 | |||||
| LUCAS, Anthony Ronald | Amministratore | Flat 12 Beatrix House 208 Old Beatrix Road SW5 0BP London | British | 30771870001 | ||||||
| MARRINAN, James | Amministratore | 206815 Hot Springs Place Agoura Hills California Ca91301 FOREIGN Usa | American | 17905570001 | ||||||
| MEDLICOTT, William Jonathan | Amministratore | Wild Boars Monteswood Lane RH17 7NS Horsted Keynes West Sussex | England | English | 44636500002 | |||||
| POHL, Henry Theodore | Amministratore | 227 Hanworth Road TW12 3EF Hampton Middlesex | British | 32450180001 | ||||||
| SANITSKY, Robert | Amministratore | 9100 Wilshire Boulevard Suite 600 90212 Beverley Hills Los Angeles California Usa | Usa | 53433450001 | ||||||
| SMITH, Kathryn | Amministratore | 9 Hanover Steps Saint Georges Fields W2 2YG London | British | 77161950001 | ||||||
| TILL, Stewart Myles | Amministratore | Barrymore 6 High Street RG10 8HY Wargrave Berkshire | British | 24204890001 | ||||||
| WILLIAMS, Lucinda Mary | Amministratore | 34 Helena Road SL4 1JN Windsor Berkshire | British | 55121890001 |
THE UK CHANNEL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee & debenture | Creato il 06 feb 1991 Consegnato il 14 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreements dated 5/2/91 and all other facility documents on defined | |
Brevi particolari (See doc M132 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Amanded and restated copyright collaterol assignment agreement | Creato il 05 feb 1991 Consegnato il 14 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined) | |
Brevi particolari All of the company's right title and interest in the " collaferal" (see form 395 ref M108 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trademark security agreement | Creato il 05 feb 1991 Consegnato il 14 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined) | |
Brevi particolari All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 395 - ref M124 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Us security agreement (created by the home service channel limited now k/a the U.K. channel limited) | Creato il 05 feb 1991 Consegnato il 14 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility agreement dated 10TH february 1991 and all other facility documents (as defined) | |
Brevi particolari All of the company's right title and interest in the "collaferal" (see form 396- ref m 116 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0