NEWINCCO 839 LIMITED

NEWINCCO 839 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWINCCO 839 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02301998
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWINCCO 839 LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova NEWINCCO 839 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Clock House
    Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWINCCO 839 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DELANCEY ESTATES LIMITED07 gen 199707 gen 1997
    ARTESIAN ESTATES PLC23 dic 198823 dic 1988
    FAROVER PLC04 ott 198804 ott 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWINCCO 839 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWINCCO 839 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2013

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 lug 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2012

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 lug 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2011

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square London W1J 6ER in data 06 feb 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 gen 2010

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 22 gen 2010

    • Capitale: GBP 218,441.77
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share redemption reserve & share prem acc cancelled 21/01/2010
    RES13

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    4 pagine363a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed delancey estates LIMITED\certificate issued on 09/06/08
    2 pagineCERTNM

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    18 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2005

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di NEWINCCO 839 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Segretario
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    93189540002
    PORTMAN ADMINISTRATION 1 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Amministratore
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    93189540002
    PORTMAN ADMINISTRATION 2 LIMITED
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    Amministratore
    6th Floor Lansdowne House
    Berkeley Square
    W1J 6ER London
    88224330004
    CUNNINGHAM, Antony Paul
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    British44992380001
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Segretario
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    British4573140002
    BREEN, Richard Christopher
    60 Webbs Road
    SW11 6SE London
    Amministratore
    60 Webbs Road
    SW11 6SE London
    United KingdomBritish37178200001
    BROOKSBANK, George Edward Hugh
    58 Cumberland Street
    SW1V 4LZ London
    Amministratore
    58 Cumberland Street
    SW1V 4LZ London
    British45758820002
    CUNNINGHAM, Antony Paul
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Forest Lodge High Street
    Balcombe
    RH17 6JZ Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish44992380001
    DIXON, Peter Herbert, The Honourable
    The Old Rectory
    Yattendon
    RG18 0UR Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Yattendon
    RG18 0UR Thatcham
    Berkshire
    British37300330001
    EDELMAN, Martin Lee
    Hillside Road Rye
    Westchester
    New York 10580
    55
    United States
    Amministratore
    Hillside Road Rye
    Westchester
    New York 10580
    55
    United States
    United StatesAmerican133811640001
    EMMETT, Graham Anthony Johnathan
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Rushmead
    Leigh Place
    KT11 2HL Cobham
    Surrey
    British66041940002
    GARFIELD, John Stuart Godwin
    20 Egerton Gardens Mews
    SW3 London
    Amministratore
    20 Egerton Gardens Mews
    SW3 London
    British22311780001
    GOSWELL, Paul Jonathan
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    Amministratore
    Mulberry Lodge
    Mill Hill Barnes
    SW13 0HS London
    United KingdomBritish60475780002
    HADEN SCOTT, Timothy
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    Amministratore
    6 Russell Hill
    CR8 2JA Purley
    Surrey
    British63220740001
    HYAMS, David Joseph
    Milner House
    Manchester Square
    W1A 1BA London
    Amministratore
    Milner House
    Manchester Square
    W1A 1BA London
    British44894350003
    KATZ, Richard William
    Villa La Sirena
    Vico Dell Olivetta 12
    FOREIGN Mortola Inferiore 18039 (Im)
    Ventimiglia Italy
    Amministratore
    Villa La Sirena
    Vico Dell Olivetta 12
    FOREIGN Mortola Inferiore 18039 (Im)
    Ventimiglia Italy
    British59404510001
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Amministratore
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritish6639590001
    MANSER, Peter John
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    Amministratore
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    British71263200001
    MOSS, Andrew Graham
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    Amministratore
    244 Willesden Lane
    NW2 5RE London
    United KingdomBritish4573140002
    RAZZALL, Edward Timothy
    9b Landsdowne Walk
    W11 9LN London
    Amministratore
    9b Landsdowne Walk
    W11 9LN London
    British72530280002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Amministratore
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Amministratore
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001

    NEWINCCO 839 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A fixed and floating security document
    Creato il 29 nov 2001
    Consegnato il 12 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by any obligor to any finance party under or in connection with any finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 01E Royal Bank of Scotland PLC (The "Agent" Which Expression Includes Its Successors and Assigns as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties)
    Transazioni
    • 12 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of securities
    Creato il 25 mag 2000
    Consegnato il 30 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the loan agreement dated 7 february 2000
    Brevi particolari
    All stocks shares bonds warrants or other securities from time to time and all income derived therefrom.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement and charge on cash deposit
    Creato il 15 set 1999
    Consegnato il 30 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the company to the chargee under clause 6.4 (indemnity from the borrower) of the credit agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All of the company's right title and interest in and to the deposit account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 15 set 1999
    Consegnato il 30 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement) under each finance document (as defined) (other than after the final maturity date, the deposit agreement and clause 6.4 (indemnity from the borrower) of the credit agreement to the extent that the company has provided cash cover in respect of any guarantees)
    Brevi particolari
    All the shares and by way of a first fixed charge all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 ago 1996
    Consegnato il 03 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks, P.L.C. (as security trustee) and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h land to the west of main road leaves green biggin hill bromley kent t/n-SGL573654. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks, P.L.C. (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 ago 1996
    Consegnato il 03 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks, P.L.C. (as security trustee) and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h plots 5, 25, 26, 27, 31 and 32 vincent square biggin hill bromley t/n-SGL573654. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks, P.L.C. (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 feb 1996
    Consegnato il 01 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a sillwood hall montpelier road brighton east sussex t/no ESX191041 with the goodwill of the business and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Plcas Trustee for Itself and Aib Finance Limited
    Transazioni
    • 01 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 dic 1995
    Consegnato il 16 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to allied irish banks,P.L.C. In its capacity as trustee for itself and aib finance limited and/or aib finance limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property k/as land at maiden lane and exchange court,london WC1 being part of land under t/no.NGL654987.specific charge the goodwill and connection of the business or businesses from time to time carried on by or for the account of the company upon all or any part of the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-101 and 103 ross road south norwood. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-flat 17, flat 70, flat 82 and garage 3 greenhill high street hampstead. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-12A, 22 cunningham court maida vale london W9. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-5, 40 parking bay 3, parking bay 5, parking bay 6, manor house marylebone road london NW1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The oasis 122-124 widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-forsythe shades court 29/31 the avenue beckenham kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-eastland court 163A widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-westland lodge 159 widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-fairline court 2 oakwood avenue beckenham kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-andace park 127 and 135-151 widmore road bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-andhurst court 2A coombe lane west (previously known as 2, 4 and 6 gloucester road) kingston-upon-thames surrey. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-androse gardens bickerley road ringwood hants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-andbourne court admiralty road southbourne bournemouth. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-andwell court trinity place eastbourne east sussex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-hopton court forge close hayes bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-andringham lodge 51 palace grove bromley kent. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 23 ott 1995
    Consegnato il 25 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-andridge court 162-164 kingston road merton park london SW19. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NEWINCCO 839 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 giu 2013Data di scioglimento
    26 gen 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian David Holland
    The Clock House
    87 Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex
    Praticante
    The Clock House
    87 Paines Lane
    HA5 3BZ Pinner
    Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0