SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02302277
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHURCHFIELD PARK (NOTTINGHAM) LIMITED05 ott 198805 ott 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2011

    Stato del capitale al 21 ott 2011

    • Capitale: GBP 147,494
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    28 pagineAA

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    25 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Janette Malham come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    CHURCH, John Andrew
    1 Rectory Cottages
    Gedling
    NG4 4BH Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    1 Rectory Cottages
    Gedling
    NG4 4BH Nottingham
    Nottinghamshire
    British59407160001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British84003280001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305770001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Segretario
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Amministratore
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    CARPENTER, Terence John
    Green Pastures Farm 106 Bridle Road
    Burton Joyce
    NG14 5FP Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Green Pastures Farm 106 Bridle Road
    Burton Joyce
    NG14 5FP Nottingham
    Nottinghamshire
    British15679280001
    CHURCH, John Andrew
    1 Rectory Cottages
    Gedling
    NG4 4BH Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    1 Rectory Cottages
    Gedling
    NG4 4BH Nottingham
    Nottinghamshire
    British59407160001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    HENDERSON, David Greig
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Amministratore
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    EnglandBritish6112570002
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15223790003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MACINTOSH, Michael
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish137864880001
    MALHAM, Janette
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish91088900004
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Amministratore
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    NEWCOMBE, John Harry
    25 Boxley Drive
    West Bridgford
    NG2 7GQ Nottingham
    Amministratore
    25 Boxley Drive
    West Bridgford
    NG2 7GQ Nottingham
    British11916170001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    British34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 2004
    Consegnato il 28 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 28 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 ago 2002
    Consegnato il 03 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 03 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2002
    Consegnato il 11 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee (as security agent for the beneficiaries) (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 set 1993
    Consegnato il 09 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 09 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 gen 1992
    Consegnato il 29 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 1990
    Consegnato il 04 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Churchfield nursing home, south east radford, grove lane radford, nottinghamshire title no nt 238835. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1989
    Consegnato il 11 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £61,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Including churchfield home radford nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • British Coal Enterprise Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 gen 1989
    Consegnato il 21 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £536,000
    Brevi particolari
    F/H land off radford grove lane hartley road nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Skipton Building Society
    Transazioni
    • 21 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 08 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE (CLYDE) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0