ACLM LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACLM LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02303650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACLM LIMITED?

    • (5242) /

    Dove si trova ACLM LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACLM LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ETHEL AUSTIN LIMITED10 apr 199010 apr 1990
    ETHEL AUSTIN (RETAIL) LIMITED17 gen 198917 gen 1989
    FATHOMKEY LIMITED10 ott 198810 ott 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACLM LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 set 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per ACLM LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 ott 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 apr 2011

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 ott 2010

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 11 st. James's Square Manchester M2 6WH in data 28 giu 2010

    2 pagineAD01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagine2.34B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 apr 2009

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 14 ott 2008

    14 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    9 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    94 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    5 pagine2.16B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ethel austin LIMITED\certificate issued on 20/05/08
    3 pagineCERTNM

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    legacy

    3 pagine403a

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    6 pagine395

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di ACLM LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCDONALD, Paul Andrew
    92 Leyfield Road
    L12 9HB Liverpool
    Segretario
    92 Leyfield Road
    L12 9HB Liverpool
    British122906510001
    COOPER, Simon John
    The Laurels
    De Beauvoir Chase
    CM11 1PR Downham Billericay
    Essex
    Amministratore
    The Laurels
    De Beauvoir Chase
    CM11 1PR Downham Billericay
    Essex
    United KingdomBritishRetail Managing Director109379230001
    OGDEN, Ian
    21 The Paddocks
    Queniborough Hall, Queniborough
    LE7 3DZ Leicester
    Amministratore
    21 The Paddocks
    Queniborough Hall, Queniborough
    LE7 3DZ Leicester
    BritishRetail Director115304700001
    SMITH, Stephen Rushworth
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector6894950002
    SMITH, Stephen Rushworth
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    British6894950002
    WILLIAMS, Stephen Robert
    1 Wellfield Lane
    L40 6HH Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    1 Wellfield Lane
    L40 6HH Ormskirk
    Lancashire
    BritishCompany Director911620003
    ETHEL AUSTIN RETAIL LIMITED
    School Lane
    L34 9GJ Knowsley
    Merseyside
    Segretario
    School Lane
    L34 9GJ Knowsley
    Merseyside
    109108660001
    AUSTIN, Edna Patricia
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director15774100001
    AUSTIN, Graeme Roger
    14 Vyner Close
    Noctorum
    L43 7XL Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    14 Vyner Close
    Noctorum
    L43 7XL Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director21426780001
    AUSTIN, Ronald George
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Amministratore
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    BritishCompany Director36193370001
    BAILEY, Susan
    14 Gayton Lane
    CH60 3SJ Gayton
    Wirral
    Amministratore
    14 Gayton Lane
    CH60 3SJ Gayton
    Wirral
    BritishDirector82196590001
    BOURN, Jonathan Martin
    White Oak
    Highwood Hill Mill Hill
    NW7 4ET London
    Amministratore
    White Oak
    Highwood Hill Mill Hill
    NW7 4ET London
    United KingdomBritishInvestment Director76914860001
    BUCKLEY, Terrance Clive
    1 Lower Farm Court
    Duckington
    SY14 8LQ Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    1 Lower Farm Court
    Duckington
    SY14 8LQ Malpas
    Cheshire
    BritishCompany Director41994000003
    BULLIVANT, Peter Wild
    Tudor Farm
    Kinnerton Road Dodleston
    CH4 9LP Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Tudor Farm
    Kinnerton Road Dodleston
    CH4 9LP Chester
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor50290920002
    CARR, Jonathan Charles
    92 Wigton Lane
    LS17 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    92 Wigton Lane
    LS17 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director108327450001
    CARROLL, Raymond Joseph
    Millbrook
    Aldersey Lane
    CH3 9EH Tattenhall
    Chester
    Amministratore
    Millbrook
    Aldersey Lane
    CH3 9EH Tattenhall
    Chester
    BritishCompany Director98559940001
    DUXBURY, Thomas Ian
    12 Sandon Grove
    Rainford
    WA11 8AU St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    12 Sandon Grove
    Rainford
    WA11 8AU St Helens
    Merseyside
    BritishCompany Director30619820001
    HENDERSON, David
    21 Derby Road
    Freshfield Formby
    L37 7BN Liverpool
    Amministratore
    21 Derby Road
    Freshfield Formby
    L37 7BN Liverpool
    BritishCompany Director54260780001
    HOSKINSON, Philip Edward
    The Hollies
    11 Links Hey Road
    CH48 1NA Caldy
    Merseyside
    Amministratore
    The Hollies
    11 Links Hey Road
    CH48 1NA Caldy
    Merseyside
    United KingdomBritishCompany Director69384790002
    HOWE, Ian Mckinlay
    Whitefield 82 Cwm Road
    Dyserth
    LL18 6HR Rhyl
    Clwyd
    Amministratore
    Whitefield 82 Cwm Road
    Dyserth
    LL18 6HR Rhyl
    Clwyd
    BritishCompany Director14949090001
    KONRAD, Glenys
    9 Fairmeadside
    IG10 4RH Loughton
    Essex
    Amministratore
    9 Fairmeadside
    IG10 4RH Loughton
    Essex
    EnglandBritishCompany Director21426790002
    KONRAD, Glenys
    91 Pipers Lane
    Heswall
    L60 9HR Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    91 Pipers Lane
    Heswall
    L60 9HR Wirral
    Merseyside
    BritishCompany Director21426790001
    KONRAD, Janina Maria
    55 Canonbury Park South
    Islington
    N1 2JL London
    Amministratore
    55 Canonbury Park South
    Islington
    N1 2JL London
    BritishNone79806440001
    KONRAD, Janusz
    36 Beresford Road
    L43 1XJ Birkenhead
    Merseyside
    Amministratore
    36 Beresford Road
    L43 1XJ Birkenhead
    Merseyside
    BritishCompany Director15776020001
    LAING, Stephen George
    27 Ashburton Road
    CH43 8TN Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    27 Ashburton Road
    CH43 8TN Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritishChartered Accountant24914370001
    O'REILLY, Rhian Ellis
    9 Statham Way
    L39 4XR Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    9 Statham Way
    L39 4XR Ormskirk
    Lancashire
    BritishCompany Director36428700002
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Amministratore
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director69716360003
    PRESCOTT, Susan Patricia
    60 Waterside Point
    Anhalt Road
    SW11 4PD London
    Amministratore
    60 Waterside Point
    Anhalt Road
    SW11 4PD London
    EnglandBritishCompany Director15761740002
    WILLIAMS, Stephen Robert
    1 Wellfield Lane
    L40 6HH Ormskirk
    Lancashire
    Amministratore
    1 Wellfield Lane
    L40 6HH Ormskirk
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director911620003

    ACLM LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7 january 2008 and
    Creato il 18 dic 2007
    Consegnato il 22 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenant's interest in the sub-lease between bejam group PLC and shoprite limited, registered in the land register of scotland under t/no. STG4414, being a sub-lease of the subjects k/a 1/3 york square, grangemouth.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 22 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 03 ago 2007
    Consegnato il 14 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 14 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 21 giu 2007
    Consegnato il 12 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re ethel austin limited, business premium account, account number 20064823. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 feb 2006
    Consegnato il 27 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parities on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest from time to time in and to the real property being l/h property at 88 east street, bedminster, bristol t/n BL90536 l/h property at 55 bethcar street, ebbwvale, blaenau, gwent t/n CYM258578 l/h property at 266-270 holderness road, kingston upon hull t/n HS80713 for further details of property charged please refer to the form 395 the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital; the investments; by way of first floating charge the whole of the company's undertaking andassets, present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 20 july 2004 and
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 31 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secure party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sub-tenant's interest in the sub-lease between bejam group PLC and shopright limited with t/no. STG4414 being a sub-lease of the ground and first floor of the shop premises k/a 1/3 york square, grangemouth.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27 july 2004 and
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 31 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    54 & 56 channel street galashiels.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 21 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest from time to time in and to the real property the accounts the intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company investments by way of first floating charge the whole of the companys undertaking and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 21 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 21 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property at 88 east street bedminster bristol (absolute) t/no AV39486, f/h property at 55 bethcar street ebbw vale blaenau gwent (absolute) t/no WA859724, l/h property at 266-270 holderness road kingston-upon-hull (absolute) t/no HS80713 for further details of the properties charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 21 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 28 july 2003 and
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 01 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole the sub-tenants interest in the sub-lease between bejam group PLC and shoprite limited t/n STG4414 being a sub-lease of the ground and first floor of the shop premises k/a 1/3 york square grangemouth.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Secured Trustee
    Transazioni
    • 01 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 28 july 2003 and
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 01 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground extending to three hundred and sixty two square yards or thereby being the plot of ground together with building erected thereon and k/a number fifty four and fifty six channel street galashiels second that portion of the flat on the first floor above the ground floor of the said building which forms part of a room jutting into the building erected on the adjoining plot of ground and third that portion of the flat on the second floor above the ground floor of the said building which portion forms part of a room also jutting into the building erected onthe said adjoining plot. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Secured Trustee
    Transazioni
    • 01 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 25 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or each other obligor to the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 8 to 11 queen street south shields title absolute t/n TY173653, f/h land and buildings k/a 40 chester street flint title absolute t/NWA368087 WA407702 WA432527 and WA485363.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented in scotland for registration on 1 july 2002 and
    Creato il 20 giu 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a 54-56 channel street, galashiels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28TH june 2002
    Creato il 20 giu 2002
    Consegnato il 04 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Ground and first floor of the shop premises k/a 1/3 york square grangemouth.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 giu 2002
    Consegnato il 26 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, each other chargor and any other present or future subsidiary of the company or of any chargor to the finance parties or any of them. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 16/30 campbell place stoke on trent & 16/18 south wolfe street stoke on trent staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a unit c victoria house 1 market square shipley west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 giu 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 157 to 163 high streetchatham kent title number K278853. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20,22,24,26 & 28 front street stanley durham. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    140 and 142 lord street fleetwood lancashire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    88 east street bedminster bristol. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    42 high street wombwell barnsley south yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 and 3 north seaton road and 2 and 4 station road ashington northumberland. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 55 bethcar street ebbw vale blaenau gwent. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 21 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    8 to 11 queen street south shields tyne and wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1996
    Consegnato il 25 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 603 west derby road, liverpool. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ACLM LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 ott 2009Fine dell'amministrazione
    15 apr 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Phillip Francis Duffy
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Praticante
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    David John Whitehouse
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Praticante
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    2
    DataTipo
    23 mag 2012Data di scioglimento
    08 ott 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Phillip Francis Duffy
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Praticante
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    David John Whitehouse
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Praticante
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0