HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED

HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02303704
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHTHIRD LIMITED11 ott 198811 ott 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Penman Way, Grove Park Leicester Leicestershire LE19 1st a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 08 ott 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Gerard Edward Nieuwenhuys come amministratore in data 07 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2015

    Stato del capitale al 24 apr 2015

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2014

    Stato del capitale al 29 apr 2014

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Adam Collinson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeremy Mallett come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Kurnick come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Page-Morris come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Laurence Vaughan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di David Kevin Jones come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 23 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    148166240001
    COLLINSON, Adam
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish136375910001
    BAKER, Lorna Margaret
    47 Summerleys Road
    HP27 9DS Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    47 Summerleys Road
    HP27 9DS Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British48588210001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    British105829630002
    JONES, David Kevin
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    157724100001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Segretario
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    British147628740001
    CARPENTER, Mark Gwilym
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish105829630002
    HAMILTON, John
    12 Hardwick Close
    SL6 5JU Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    12 Hardwick Close
    SL6 5JU Maidenhead
    Berkshire
    British26625940001
    KURNICK, Robert Harold
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    Amministratore
    670 Pleasant
    Birmingham
    Michigan 48009
    Usa
    United StatesAmerican82981540007
    MALLETT, Jeremy Richard
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish71752820001
    MORRIS, Mark Christopher
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    Amministratore
    Curtis House
    LE15 9JG Stoke Dry
    Rutland
    EnglandBritish147628740001
    NIEUWENHUYS, Gerard Edward
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish66435290003
    PAGE-MORRIS, Geoffrey Giovanni
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish105444550002
    VAUGHAN, Laurence Edward William
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Penman Way
    Grove Park
    LE19 1ST Leicester
    2
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandEnglish40326440010

    HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 20 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a valley road hughenden way high wycombe buckinghamshire t/n BM19263. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 set 2000
    Consegnato il 03 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a valley road hughenden valley high wycombe buckinghamshire t/no. BM128087. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1998
    Consegnato il 13 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a land and buildings on the south east side of hughenden road high wycombe t/n BM19263 and l/a land and buildings on the south east side of friars gardens hughendedn high wycombe t/n BM128087 by way of assignment the benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Group Limited
    Transazioni
    • 13 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Residual floating charge
    Creato il 31 dic 1998
    Consegnato il 13 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge the company's undertaking property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Group Limited
    Transazioni
    • 13 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 26 gen 1993
    Consegnato il 28 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of overdraft facilities (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    First all the company's present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the company's right title and interest therein. Secondly all moneys from time to time payable under any insurances in respect of motor vehicles. And thirdly all goods given in exchange for the motor vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transazioni
    • 28 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 01 mag 1992
    Consegnato il 02 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's present and future stock of used vehicles and all the company's right, title and interest therein all moneys from time to time payable under any insurances all debts from time to time owing to the company in respect of motor vehicles. See doc for details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 set 1989
    Consegnato il 03 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 set 1989
    Consegnato il 19 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3 I PLC
    Transazioni
    • 19 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 set 1989
    Consegnato il 15 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brevi particolari
    All monies from time to time owing to the company by the chargor in respect of refund monies (continued see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bmw Finance (GB) Limited
    Transazioni
    • 15 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 14 set 1989
    Consegnato il 15 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First all the chargors present and future stock of used motor vehicles of whatsoever nature and all the chargor's right title and interest therein (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited.
    Transazioni
    • 15 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HUGHENDEN MOTOR COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 set 2015Inizio della liquidazione
    16 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0