SPX AIR TREATMENT LIMITED

SPX AIR TREATMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPX AIR TREATMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02307476
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPX AIR TREATMENT LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SPX AIR TREATMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Plenty House, Hambridge Road
    Newbury
    RG14 5TR Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPX AIR TREATMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FLAIR LIMITED19 feb 199819 feb 1998
    FLAIR INTERNATIONAL LIMITED09 nov 199309 nov 1993
    PNEUMATIC PRODUCTS LIMITED21 nov 198821 nov 1988
    RAPID 7037 LIMITED20 ott 198820 ott 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPX AIR TREATMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SPX AIR TREATMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 13 set 2013

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced to zero 10/09/2013
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Andrew Reilly il 14 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 06 ago 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 14 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Lucius Lilly il 14 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Kevin Lucius Lilly il 14 gen 2013

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Nomina di Jeremy Wade Smeltser come amministratore in data 31 mag 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Patrick Joseph O'leary come amministratore in data 31 mag 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Chi sono gli amministratori di SPX AIR TREATMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    Charlotte
    13320
    Nc 28277
    Usa
    Segretario
    Ballantyne Corporate Place
    Charlotte
    13320
    Nc 28277
    Usa
    American110636870001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    Charlotte
    13320
    Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne Corporate Place
    Charlotte
    13320
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican110636870001
    REILLY, Michael Andrew
    Ballantyne Corporate Place
    Charlotte
    13320
    Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne Corporate Place
    Charlotte
    13320
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican103500870001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    28277 Charlotte
    13515
    North Carolina
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne Corporate Place
    28277 Charlotte
    13515
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmerican163313000001
    BEARSE, Richard A
    Charlotte
    North Carlolina
    FOREIGN Mecklenburg
    Usa 28216
    Segretario
    Charlotte
    North Carlolina
    FOREIGN Mecklenburg
    Usa 28216
    American67509550003
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Segretario
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Segretario
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    MOORE, Robert Oscar
    2600 South East
    41st Street
    FOREIGN Ocala
    Florida 32671
    Usa
    Segretario
    2600 South East
    41st Street
    FOREIGN Ocala
    Florida 32671
    Usa
    British29438920001
    PORTER, Timothy John
    8 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    8 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    British54677520002
    WILTON, Malcolm Clive
    Ty Gwyn
    Catbrook
    NP16 6ND Chepstow
    Gwent
    Segretario
    Ty Gwyn
    Catbrook
    NP16 6ND Chepstow
    Gwent
    British24038770001
    AUSTIN, Mark Albert
    68 Grange Road
    SO24 9HF New Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    68 Grange Road
    SO24 9HF New Alresford
    Hampshire
    United KingdomBritish112735960001
    BEARSE, Richard A
    Charlotte
    North Carlolina
    FOREIGN Mecklenburg
    Usa 28216
    Amministratore
    Charlotte
    North Carlolina
    FOREIGN Mecklenburg
    Usa 28216
    American67509550003
    BELL, William Forrest
    1890 Clatter Bridge Road
    Ocala
    Florida
    34471
    Usa
    Amministratore
    1890 Clatter Bridge Road
    Ocala
    Florida
    34471
    Usa
    Usa38682080001
    BRICKER, Ross Benjamin
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Amministratore
    2401 Pioneer Road
    JI 60201 Evanston
    Illinios Ji 60201
    Usa
    Canadian105172080001
    CLARK, David
    226 Huntly Place
    28207 Charlotte
    North Carolina
    American
    Amministratore
    226 Huntly Place
    28207 Charlotte
    North Carolina
    American
    American63900120001
    CROSS, Arthur Robert
    1446 West Norton Avenue Apartment L9
    Muskegon
    Michigan Mi 49441
    Usa
    Amministratore
    1446 West Norton Avenue Apartment L9
    Muskegon
    Michigan Mi 49441
    Usa
    American79398510001
    DIXON, Ian
    3 Birch Close Boundstone
    Wrecclesham
    GU10 4TJ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    3 Birch Close Boundstone
    Wrecclesham
    GU10 4TJ Farnham
    Surrey
    British38544410002
    DOHERTY, James Patrick
    Whitebridge Manor
    Ballycasheen
    IRISH Killarney Co Kerry Ireland
    Amministratore
    Whitebridge Manor
    Ballycasheen
    IRISH Killarney Co Kerry Ireland
    Irish53202870001
    GELINAS, Michael Ernest
    5590 Se 42nd Avenue
    Ocala
    Florida
    34471
    Usa
    Amministratore
    5590 Se 42nd Avenue
    Ocala
    Florida
    34471
    Usa
    Usa38682180001
    KEARNEY, Christopher James
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    Amministratore
    14675 Rudolph Dadey Drive
    Charlotte
    Nc2827749456
    Usa
    American85114770001
    KING, David Reeder
    6000 Fairview Road
    Charlotte
    Nc 28210
    Usa
    Amministratore
    6000 Fairview Road
    Charlotte
    Nc 28210
    Usa
    American64926580001
    MILLER, Keith
    Flair Ocala 4647 Sw 40th Avenue
    Ocala
    Fl 34474-5799
    Usa
    Amministratore
    Flair Ocala 4647 Sw 40th Avenue
    Ocala
    Fl 34474-5799
    Usa
    American73942130001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    6524 Chipstead Lane
    28277 Charlotte
    North Carolina Nc 28277
    Usa
    United StatesAmerican61807850002
    PERRIS, Kevin David
    8 Rosina Close
    PO7 8SL Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    8 Rosina Close
    PO7 8SL Waterlooville
    Hampshire
    British61526360001
    PORTER, Timothy John
    8 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    8 Saxon Road
    SO23 7DJ Winchester
    Hampshire
    British54677520002
    ROWE, John David
    14 The Gorseway
    PO11 0DR Hayling Island
    Hampshire
    Amministratore
    14 The Gorseway
    PO11 0DR Hayling Island
    Hampshire
    British23159290001
    SHAWL, Harry Michael
    73 Sinah Lane
    PO11 0HJ Hayling Island
    Hampshire
    Amministratore
    73 Sinah Lane
    PO11 0HJ Hayling Island
    Hampshire
    American37979170001
    SWINKELS, Wilhelmus Johannes Martinus
    Hurkseweg 1b
    Best
    5681 Pv
    Netherlands
    Amministratore
    Hurkseweg 1b
    Best
    5681 Pv
    Netherlands
    Dutch69627510001
    WILTON, Malcolm Clive
    Ty Gwyn
    Catbrook
    NP16 6ND Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    Ty Gwyn
    Catbrook
    NP16 6ND Chepstow
    Gwent
    WalesBritish24038770001
    WINOWIECKI, Ronald Lee
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    Amministratore
    8707 Calumet Farms Drive
    Wexham
    Nc 28173
    Usa
    American95572300001

    SPX AIR TREATMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 05 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 07 giu 1995
    Consegnato il 21 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement. All interest (if any) then owing and thereafter to become owing in respect of any such account(s) or deposit(s). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1991
    Consegnato il 07 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • First Union National Bank of North Carolina
    Transazioni
    • 07 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1991
    Consegnato il 07 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • First Union Commercial Corporation
    Transazioni
    • 07 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 12 lug 1990
    Consegnato il 24 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0