POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED

POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02316967
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Fleet Place
    EC4M 7QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRUEHIGH LIMITED14 nov 198814 nov 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    25 pagineAM23

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    105 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 16 dic 2021

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    29 pagineAM16

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    25 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    34 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    8 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Desford Lane Kirby Muxloe Leicestershire LE9 2BJ a C/O Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL in data 04 ago 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di Hemant Patel come amministratore in data 20 lug 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hemant Patel come segretario in data 20 lug 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Trident Business Park Leeds Road Huddersfield HD2 1UA a Desford Lane Kirby Muxloe Leicestershire LE9 2BJ in data 08 apr 2020

    2 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    18 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 023169670042, creata il 23 mag 2019

    8 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYUB, Abdul Aziz
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish16280660001
    COLLINSON, Martin Donald
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    Segretario
    1 Badger Gate
    Meltham
    HD9 5LB Holmfirth
    British98796330005
    KEMP, Helen Anne
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Birch Mews Oaklands Manor
    Long Causeway Adel
    LS16 8NX Leeds
    West Yorkshire
    British48922660002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Segretario
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    LETHAM, Ian Ritchie
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    Segretario
    45 Palin Wood Road
    Delph
    OL3 5UW Oldham
    Lancashire
    British9252900001
    PATEL, Hemant
    Kirby Muxloe
    LE9 2BJ Leicestershire
    Desford Lane
    Segretario
    Kirby Muxloe
    LE9 2BJ Leicestershire
    Desford Lane
    240487120001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    SISSON, Hamish Paul
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    20 Park View Court
    29 Street Lane
    LS8 1BS Leeds
    West Yorkshire
    British43874820001
    BLISS, Henry Donald
    8 Cumberland Mills Square
    E14 3BH London
    Amministratore
    8 Cumberland Mills Square
    E14 3BH London
    Canadian4094060001
    BROWN, Gary James
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    Amministratore
    3 Dewberry Fields
    Upholland
    WN8 0BQ Skelmersdale
    Lancashire
    EnglandBritish125196870001
    BURDON, Peter
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    Amministratore
    40 Firs Road
    Edwalton
    NG12 4BX Nottingham
    British70178470002
    COATES, Trevor Marwood
    Apartment 304
    Valley Mills
    HX5 9HP Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    Apartment 304
    Valley Mills
    HX5 9HP Elland
    West Yorkshire
    Australian111810490001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    ELLIS, Roy George
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    WalesBritish161784490001
    GRAY, Ian
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Flat 48 Langtons Wharf
    LS2 7EN Leeds
    Yorkshire
    British50246030002
    HAUGHTON, Townsend Andrew
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Staddlestones
    11 Oakdale Manor
    HG1 2NA Harrogate
    North Yorkshire
    South Africa39356840002
    KERRISON, Michael Arthur
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    57 Welldon Crescent
    HA1 1QP Harrow
    Middlesex
    British1452630001
    MONRO, Angus
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    84 Macclesfield Road
    SK10 4AG Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish79054360001
    PATEL, Hemant
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish104124100001
    ROELOFSE, Hendrik
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    18 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    South African40527920003
    ROSSI, Stephen Robert
    Farm
    New Lane Blackshawhead
    HX7 7JR Hebden Bridge
    Green House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Farm
    New Lane Blackshawhead
    HX7 7JR Hebden Bridge
    Green House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish84548560002
    SMITH, Martin Freeman
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Amministratore
    84 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    British44140230002
    STASSEN, Carel
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    Amministratore
    West Acre Lodge
    Linton Lane
    LS22 6HG Wetherby
    Uk
    South African104942950001
    SULEMAN, Ebrahim
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 St Marys Avenue
    WF17 7PT Batley
    West Yorkshire
    EnglandBritish52733940001
    VISSER, Johan Jacobus
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    22 Mackenzie Gardens
    East Kilbride
    G74 4SA Glasgow
    Lanarkshire
    South African51820380002
    YORK, Ian
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    EnglandBritish197002910001

    Chi sono le persone con controllo significativo di POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Instore Limited
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Leeds Road
    HD2 1UA Huddersfield
    Trident Business Park
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione347453
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 mag 2019
    Consegnato il 23 mag 2019
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 gen 2016
    Consegnato il 28 gen 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 ago 2013
    Consegnato il 21 ago 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 21 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 21 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 mar 1996
    Consegnato il 17 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to the guarantee (as therein defined) and the expenses (as therein defined) (provided that any expenses incurred prior to an enforcement event (as therein defined) shall be consented to by poundstretcher limited and interest (as therein defined)
    Brevi particolari
    The property as defined on form 395 and. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nedcor Bank Limited
    Transazioni
    • 17 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rectification
    Creato il 17 ago 1995
    Consegnato il 18 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a debenture dated 3RD june 1994
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings Limited
    Transazioni
    • 18 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security reg in scotland 09/08/94
    Creato il 09 ago 1994
    Consegnato il 17 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The tennants interest in various leases and sub-leases relating to various properties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings Limited
    Transazioni
    • 17 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security reg in scotland 09/08/94
    Creato il 09 ago 1994
    Consegnato il 17 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The tennants interest in lease dated 30TH may and 21ST june. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings Limited
    Transazioni
    • 17 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security reg in scotland 15/06/94
    Creato il 15 giu 1994
    Consegnato il 23 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Retail warehouse unit sometime k/a unit 2 birkenshaw industrial estate uddington title no LAN211 tog with the buildings and other erections the fixed and/or heritable plant machinery fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings Limited
    Transazioni
    • 23 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security reg in scotland 15/06/94
    Creato il 15 giu 1994
    Consegnato il 23 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    12-18 new bridge street,1 boat vennel ayr.area at east access road west harbour granton edinburgh and two other properties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings
    Transazioni
    • 23 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The debtor's present and future debts (as defined) in terms of (1) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the governor and company of the bank of scotland ("the bank") dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (midlands) limited to the bank (as amended) and (2) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the bank dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (manchester) limited to the bank (as amended)
    Brevi particolari
    Tenants interest in lease of unit 16 heathfield industrial estate prestwick the entry in column 5 above has this day been amended.J.M.evans 23/06/94.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The debtor's present and future debts (as defined) in terms of (1) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the governor and company of the bank of scotland ("the bank") dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (midlands) limited to the bank (as amended) and (2) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the bank dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (manchester) limited to the bank (as amended)
    Brevi particolari
    Unit 2,birkenshaw industrial estate,uddingston the entry in column 5 above has this day been amended.J.M.evans 23/06/94.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The debtor's present and future debts (as defined) in terms of (1) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the governor and company of the bank of scotland ("the bank") dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (midlands) limited to the bank (as amended) and (2) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the bank dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (manchester) limited to the bank (as amended)
    Brevi particolari
    Tennants interest in lease of unit at west harbour road,granton the entry in column 5 above has this day been amended.J.M.evans 23/06/94.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The debtor's present and future debts (as defined) in terms of (1) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the governor and company of the bank of scotland ("the bank") dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (midlands) limited to the bank (as amended) and (2) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the bank dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (manchester) limited to the bank (as amended)
    Brevi particolari
    388/406 great northern road,aberdeen the entry in column 5 above has this day been amended.J.M.evans 23/06/94.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 10 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The debtor's present and future debts (as defined) in terms of (1) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the governor and company of the bank of scotland ("the bank") dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (midlands) limited to the bank (as amended) and (2) guarantee by brown & jackson PLC in favour of the bank dated 15 may 1990 of all monies and liabilities for the time being due or incurred by brown & jackson enterprise properties (manchester) limited to the bank (as amended)
    Brevi particolari
    14/18 new bridge street,ayr the entry in column 5 above has this day been amended.J.M.evans 23/06/94.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 giu 1994
    Consegnato il 15 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • B & J Holdings Limited
    Transazioni
    • 15 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 09 mar 1994
    Consegnato il 10 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) (other than any obligations and liabilities of a & g imports limited) to the chargee (the security agent) as agent and trustee for itself, the facility agent and each of the banks (as defined) supplemental to the debenture dated 10TH january 1992
    Brevi particolari
    L/H property k/as unit 8 boucher retail park belfast t/no 162126 see schedule for details of various properties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 24 ago 1993
    Consegnato il 13 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the debenture dated 10TH january 1992
    Brevi particolari
    All the properties as set out in schedule 1 to the form 395 together with buildings & fixtures thereon the proceeds of sale & the benefit of any covenants for title the benefit of all licences etc,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Agent & Trustee for Itself the Facility Agent & Each of the Banks
    Transazioni
    • 13 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 02 apr 1993
    Consegnato il 22 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from each obligor (as defined) other than a & c imports limited to midland bank PLC as agent and trustee for itself,the facility agent and each of the banks (as defined) under the terms of the finance documents or otherwise
    Brevi particolari
    The properties referred to in the schedule tog with all buildings and fixtures the proceeds of sale the benefit of all licences and all policies of insurance and contracts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for Itself,the Facility Agent and Each of the Banks
    Transazioni
    • 22 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the secured liabilities as defined in the composite guarantee and debenture dated 10/01/92 please see doc M320C for details
    Brevi particolari
    Unit 2 birkenshaw industrial estate rannoch road uddingston title no LAN211.
    Persone aventi diritto
    • Middland Bank PLC(As Agent)
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 24 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the secured liabilities as defined in the composite guarantee and debenture dated 10/01/92 please see doc M316C for details
    Brevi particolari
    Ground and first floor premises k/a and forming 1 to 5 brandon street and 128 to 130 quarry street hamilton title no LAN51469.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 23 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the secured liabilities as defined in the composite guarantee and debenture dated 10/01/92 please see doc M319C for details
    Brevi particolari
    14,16 and 18 high street galashiels selkirk shops and premises kk/a 20 high street and 2 to 6 sime street tog with fixtures and fittings please see doc M319C for details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (As Agent)
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 23 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the secured liabilities as defined in the composite guarantee and debenture dated 10/01/92 please see doc M318C for details
    Brevi particolari
    98/100 king street kilmarnock ayrshire 3/9 queen streeet and 1 princes street please see doc M318C for details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (As Agent)
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 23 gen 1992
    Consegnato il 04 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the secured liabilities as defined in the composite guarantee and debenture dated 10/01/92 please see doc M317C for details
    Brevi particolari
    100,101,103,104 and 106 south bridge edinburgh and 4-20 blair street edinburgh and the second basement at 4 blair streettog with the right title and interest in above please see doc M317C for details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC (As Agent)
    Transazioni
    • 04 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    POUNDSTRETCHER PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 lug 2020Inizio dell'amministrazione
    27 lug 2022Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    David James Costley-Wood
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Praticante
    1 St Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Christopher Robert Pole
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0