THOMAS COOK GROUP UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | THOMAS COOK GROUP UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02319744 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Alixpartners Uk Llp 6 New Street Square EC4A 3BF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BLUE SEA INVESTMENTS LIMITED | 09 feb 1994 | 09 feb 1994 |
| SKI CANADA LIMITED | 04 mag 1989 | 04 mag 1989 |
| LOPMIT LIMITED | 21 nov 1988 | 21 nov 1988 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2019 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2020 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2020 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 apr 2020 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 apr 2019 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU a C/O Alixpartners Uk Llp 6 New Street Square London EC4A 3BF in data 12 nov 2024 | 4 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU in data 25 nov 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU in data 25 nov 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Alix Partners, the Zenith Building, 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 17 feb 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 7 pagine | NDISC | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Westpoint Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ England a Alix Partners, the Zenith Building, 26 Spring Gardens Manchester Greater Manchester M2 1AB in data 07 ott 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 7 pagine | COCOMP | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 5 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Justin Lee Russell come amministratore in data 14 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Charles Donald come amministratore in data 14 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Charles Donald come amministratore in data 20 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rebecca Ann Symondson-Powell come amministratore in data 20 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Andrew Hemingway come amministratore in data 23 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joseph O'neill come amministratore in data 21 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Thomas Cook Group Management Services Limited il 22 ago 2016 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Thomas Cook Business Park Coningsby Road Peterborough Cambs PE3 8SB a Westpoint Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ in data 22 ago 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Maxwell Manson come amministratore in data 20 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Shirley | Segretario | 6 New Street Square EC4A 3BF London C/O Alixpartners Uk Llp | British | 65475670001 | ||||||
| RUSSELL, Justin Lee | Amministratore | 6 New Street Square EC4A 3BF London C/O Alixpartners Uk Llp | United Kingdom | British | 259488950001 | |||||
| THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | 63592630006 | |||||||
| BURNS, David Campbell | Segretario | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||
| DETKO, Tadeusz Stephen | Segretario | Yew Tree Barn White Horse Lane Barton PR3 5AH Preston Lancashire | British | 77446300001 | ||||||
| MCMAHON, Gregory Joseph | Segretario | Hollin Grove 5 Holly Grove Dobcross OL3 5JQ Oldham Lancashire | British | 49723980004 | ||||||
| AILLES, Ian Simon | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | 128695490001 | |||||
| ANDERSON, Ian Henry | Amministratore | 31 Carrwood WA16 8NE Knutsford Cheshire | England | British | 45953600001 | |||||
| ARTHUR, Nigel John | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | English | 175689210001 | |||||
| BURNS, David Campbell | Amministratore | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||
| BYRNE, Timothy Russell | Amministratore | Lower Hall Church Road Mellor SK6 5LY Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 49734540001 | |||||
| COE, Albert Henry | Amministratore | 48 Broad Walk SK9 5PL Wilmslow Cheshire | British | 3977310001 | ||||||
| COLLINSON, Harold Hugh | Amministratore | Raaes Wyke Longlands Road LA23 1DL Windermere Cumbria | England | British | 104953440001 | |||||
| CONSTANTI, Peter Panagiotou | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | 187275330001 | |||||
| CONSTANTI, Peter Panagiotou | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | 132639650001 | |||||
| CROSSLAND, David | Amministratore | Daisy Hill House La Cheuve Rue JE3 9EH Grouville Jersey | Jersey | British | 3977330005 | |||||
| DERBYSHIRE, Ian Richard, Mr. | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | 127988300001 | |||||
| DERBYSHIRE, Ian Richard, Mr. | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | 127988300001 | |||||
| DONALD, Alan Charles | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | England | British | 252692000001 | |||||
| GADSBY, Christopher James | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | 118396090002 | |||||
| GADSBY, Christopher James | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | 118396090001 | |||||
| HALLISEY, David Michael William | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | England | British | 1919030001 | |||||
| HEMINGWAY, Paul Andrew | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | United Kingdom | British | 188221460001 | |||||
| JARDINE, David | Amministratore | The Old Cottage Hough End SK9 7JD Alderley Edge Cheshire | British | 105046880001 | ||||||
| KANTOR, Kazimiera Teresa | Amministratore | 27 Springhill Road OX5 1RX Begbroke Oxfordshire | United Kingdom | British | 98839680001 | |||||
| MACMAHON, Michelle Louise | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | 158871950001 | |||||
| MANSON, Gavin Maxwell | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | Scotland | British | 167197560001 | |||||
| MCMAHON, Gregory Joseph | Amministratore | Hollin Grove 5 Holly Grove Dobcross OL3 5JQ Oldham Lancashire | United Kingdom | British | 49723980004 | |||||
| NIGHTINGALE, Barry Graham Kirk | Amministratore | Ravenhurst The Lane Heaton BL1 5DJ Bolton Lancashire | England | British | 80722790001 | |||||
| O'NEILL, Joseph | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | United Kingdom | British | 172615510001 | |||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Amministratore | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| RODGER, Peter Robert Charles | Amministratore | 16 Links Road Flackwell Heath HP10 9LY High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 29785680001 | |||||
| SEARY, Julia Louise | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs England | United Kingdom | British | 158190160001 | |||||
| STOEHR, Craig Anthony | Amministratore | Coningsby Road PE3 8SB Peterborough The Thomas Cook Business Park Cambs | United Kingdom | American | 177689020008 | |||||
| SYMONDSON-POWELL, Rebecca Ann | Amministratore | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | England | British | 177582690002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THOMAS COOK GROUP UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mytravel Group Limited | 06 apr 2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THOMAS COOK GROUP UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0