MORRISON HOLDINGS LIMITED

MORRISON HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORRISON HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02327554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lancaster House Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BEALAW (234) LIMITED12 dic 198812 dic 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Stato del capitale al 14 mar 2023

    • Capitale: GBP 11.10
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Interim dividend 09/03/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Awg Shelf 11 Limited come persona con controllo significativo il 03 feb 2022

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Nomina di Awg Corporate Services Limited come segretario in data 22 feb 2021

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come segretario in data 22 feb 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Wayne Paul Young come amministratore in data 15 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 29 giu 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Awg Shelf 11 Limited come persona con controllo significativo il 11 mar 2020

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Awg Shelf 11 Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Awg Shelf 11 Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AWG CORPORATE SERVICES LIMITED
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione12618899
    270129230001
    FORSTER, Jonathan David
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish101812460002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritish105433380001
    YOUNG, Wayne Paul
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish264531200001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    198551290001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Segretario
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    ANDERSON, Mark Stephen
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritish122463830003
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish203580340001
    CROSON, Roger Archibald
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    British4350003
    GREEN, Robert David
    1a Burnside Road
    White Craigs
    G46 6TT Glasgow
    Amministratore
    1a Burnside Road
    White Craigs
    G46 6TT Glasgow
    British76720550002
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Amministratore
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritish71318590003
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    British1499960006
    MACLENNAN, Norman Angus
    Croft Na Coille 25 Toberargan Road
    PH16 5HG Pitlochry
    Perthshire
    Amministratore
    Croft Na Coille 25 Toberargan Road
    PH16 5HG Pitlochry
    Perthshire
    British75374210001
    MCDOUGALL, Alastair Douglas
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    ScotlandBritish33622580001
    MORRISON, Alexander Fraser, Sir Fraser Morrison
    Teasses House Nr Ceres
    KY8 5PG Leven
    Fife
    Amministratore
    Teasses House Nr Ceres
    KY8 5PG Leven
    Fife
    United KingdomBritish4330002
    MORRISON, Gordon
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Carldane Court Bromley Lane
    SG10 6HU Much Hadham
    Hertfordshire
    EnglandBritish1087030003
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Amministratore
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    ROBERTSON, Iain Alasdair
    79/5 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Amministratore
    79/5 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    United KingdomBritish63518980002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritish105433380001
    VENABLES, Aileen Anderson
    36 Corbiehill Road
    EH4 5AS Edinburgh
    Amministratore
    36 Corbiehill Road
    EH4 5AS Edinburgh
    United KingdomBritish85155700001
    WARRACK, Anne Victoria Mary
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    United KingdomBritish123157220001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MORRISON HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Awg Shelf 11 Limited
    Capital Square
    58 Morrison Street
    EH3 8BP Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Capital Square
    58 Morrison Street
    EH3 8BP Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazioneSc115080
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MORRISON HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 apr 1992
    Consegnato il 10 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 feb 1992
    Consegnato il 20 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 dic 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 1989
    Consegnato il 28 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0