GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED

GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02330098
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    Cheshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NC2 LIMITED16 gen 199216 gen 1992
    APPFIRE LIMITED20 dic 198820 dic 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Shona Clare Searle come amministratore in data 01 lug 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Edward Dennison come amministratore in data 01 lug 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 nov 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account of the company being £211,800 be cancelled and extinguished in full and it's credited to distributable reserves 26/10/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    19 pagineAA

    Seconda presentazione per la nomina di James Edward Dennison come amministratore

    3 pagineRP04AP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    18 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    1 pagineAD04

    Dettagli del direttore cambiati per James Edward Dennison il 31 lug 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Altair Filter Technology Group Limited come persona con controllo significativo il 31 lug 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da The Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT in data 31 lug 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Daryl Everett come amministratore in data 24 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di James Edward Dennison come amministratore in data 24 set 2018

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    08 giu 2020Clarification A second filed AP01 was registered on 08/06/2020.

    Cessazione della carica di Timothy Robert Hill come amministratore in data 24 set 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    SEARLE, Shona Clare
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish203330870002
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Segretario
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    American111641000001
    HEGARTY, Colin Michael
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    Segretario
    15 Cornfields
    GU46 6YT Yateley
    Hampshire
    British14062610002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOYCE, Christian Jeremy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish174484350001
    BURKE, Mary
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    Amministratore
    4471 Chattahoochie Plantation Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30067
    Usa
    American111641000001
    CARSON, Candace
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    Amministratore
    653 Briarleigh Way
    FOREIGN Woodstock
    Georgia 30189
    America
    American111758740001
    CHURCH, Ian Harold
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    Amministratore
    25 Fairlawn Park
    GU21 4HT Woking
    Surrey
    British1750390002
    CLARK, Alyson Margaret
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish56868460002
    CLEAVER, Roy Edward
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Hill House Brightstone Lane
    Farringdon
    GU34 3ET Alton
    Hampshire
    British21416960002
    DENNISON, James Edward
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish250786800001
    ELSDON, Peter John
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Chase Warren
    Tennysons Lane
    GU27 3AF Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish67751830001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish127244240001
    EVERETT, Peter Daryl
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish127244240001
    HEINTZELMAN, Daniel
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    Amministratore
    5116 Sapphire Drive
    FOREIGN Marietta
    Georgia 30066
    Usa
    American111641060001
    HILL, Timothy Robert
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 2
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish183650700001
    HINTON, David Ian Small
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    The Old Brewery
    Hilltop Chichester Road
    GU29 9PZ Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish21416950001
    KEENAN, John Joseph
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    Amministratore
    5 Gresham Road
    CM14 4HN Brentwood
    Essex
    British106985300001
    RICHARDSON, Paul
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish174494740001
    ROBERTSON, Moria Ann
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United KingdomBritish203364460001
    SENNETT, Paul Timothy
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Omega Park
    GU34 2QE Alton
    3
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish174484310001
    STEEL, Andrew Charles
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    Amministratore
    9 Clumps Road
    Lower Bourne
    GU10 3HF Farnham
    Surrey
    EnglandBritish33164070002
    WAKE, Hilary Anne, Mrs.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish96648390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4543176
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    29 nov 201601 dic 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    GE ENERGY SERVICES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 12 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H interest in plot 3, omega park, wilsom road, alton, hampshire t/n HP481527. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The South Place Gresham Partnership 2002 Acting as Security Trustee for Itself and Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 12 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 07 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Freehold property known as plot 3 omega park wilsom road alton hampshire t/n HP481527. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 07 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stock pledge
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 07 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The entire issued share capital of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1994
    Consegnato il 18 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 3 omega park alton hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 set 1989
    Consegnato il 25 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 25 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 set 1989
    Consegnato il 02 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0