AVONSIDE ROOFING LIMITED

AVONSIDE ROOFING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVONSIDE ROOFING LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02330586
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    • Coperture (43910) / Costruzioni

    Dove si trova AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BEGBIES TRAYNOR
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEE ROOFING SERVICES LIMITED20 gen 199720 gen 1997
    LEE ROOFING SERVICES (NORTH WEST) LIMITED21 dic 198821 dic 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 ago 2023
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 ago 2023
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 ago 2022
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    72 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    73 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    73 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    52 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    56 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    51 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    29 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    105 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da The Courtyard Green Lane Heywood Lancashire OL10 2EX a 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 15 set 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Cessazione della carica di Anthony Burke come amministratore in data 23 ago 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    43 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Vincent Hughes come amministratore in data 25 giu 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Morley come amministratore in data 25 giu 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    31 pagineAA

    Cessazione della carica di Raj Bhogaita come amministratore in data 15 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Kyle Anthony Burke come amministratore in data 09 giu 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Edward Stanton come amministratore in data 01 nov 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KERSHAW, Keith
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Segretario
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    British74641230001
    BURKE, Kyle Anthony
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish219136290001
    KERSHAW, Keith
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish74641230001
    STANTON, Edward
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    Amministratore
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor
    EnglandBritish266217010001
    FARROW, Richard Kneen
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    Segretario
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    British84435750001
    KERSHAW, Keith
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    Segretario
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    British74641230001
    KERSHAW, Keith
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    Segretario
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    British74641230001
    LEE, David
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    Segretario
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    British77825310004
    WILD, Pamela Jayne
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    Segretario
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    British64167100001
    WINTER, David John
    20 Orchard Road
    SG8 5HA Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Orchard Road
    SG8 5HA Royston
    Hertfordshire
    British109020270001
    APPLETON, Nigel John
    No 3 'Fetherson'
    Westfield Close
    RG26 3YG Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    No 3 'Fetherson'
    Westfield Close
    RG26 3YG Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritish127939110001
    BHOGAITA, Rajesh Prabhashanker
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    Amministratore
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    EnglandBritish206731300001
    BRUCE, Peter
    26 Longcroft Lane
    SK8 6SE Cheadle Hulme
    Cheshire
    Amministratore
    26 Longcroft Lane
    SK8 6SE Cheadle Hulme
    Cheshire
    United KingdomBritish112684140001
    BURKE, Anthony
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish58500120002
    BURKE, Anthony
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    5 Stanney Close
    Milnrow
    OL16 4BF Rochdale
    Lancashire
    British58500120001
    CAMPBELL, William John
    45 Shevington Lane
    Shevington
    WN6 8BH Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    45 Shevington Lane
    Shevington
    WN6 8BH Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish38893410001
    CLARKE, Ian Herbert
    15 Wrenswood Drive
    Ellen Brook
    M28 7GS Worsley
    Manchester
    Amministratore
    15 Wrenswood Drive
    Ellen Brook
    M28 7GS Worsley
    Manchester
    British78560660001
    FARROW, Richard Kneen
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    Amministratore
    31 Vicarage Fields Overton Road
    Ruabon
    LL14 6LG Wrexham
    British84435750001
    FIRTH, Christopher Roger
    5 Wellhouse Close
    Wigston
    LE18 2RQ Leicester
    Amministratore
    5 Wellhouse Close
    Wigston
    LE18 2RQ Leicester
    British84838310001
    FJODOR, Albert
    30 Salt Meadows
    CW5 5HF Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    30 Salt Meadows
    CW5 5HF Nantwich
    Cheshire
    British61168380002
    HAWKES, Timothy Charles
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    WalesBritish109021220001
    HODGE, Nicholas Edwin
    5 Westgate Park
    Hough
    CW2 5GY Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    5 Westgate Park
    Hough
    CW2 5GY Crewe
    Cheshire
    British78125710001
    HOLLOWS, Darren Mark
    53 Tamworth Road
    YO30 5GJ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    53 Tamworth Road
    YO30 5GJ York
    North Yorkshire
    British78365860002
    HUGHES, Vincent
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish112684210001
    KERSHAW, Keith
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    Amministratore
    31 Stockburn Drive
    Failsworth
    M35 9SD Manchester
    EnglandBritish74641230001
    LEE, David
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    Amministratore
    1 Orchard Court
    Heath Lane
    WA3 7DH Croft
    Cheshire
    British77825310004
    LOGAN, Stuart
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    Amministratore
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    British112676540001
    LOGAN, Stuart
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    Amministratore
    Ashton Gardens
    G69 8EF Gartcosh
    Glasgow
    British112676540001
    MCGUIRE, John James
    5 Willowtree Close
    Whitley
    WN1 2LT Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    5 Willowtree Close
    Whitley
    WN1 2LT Wigan
    Lancashire
    British39572050002
    MCLOUGHLIN, Paul
    23 Sherbourne Drive
    Branston
    DE14 3GE Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    23 Sherbourne Drive
    Branston
    DE14 3GE Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish121582960001
    MORLEY, Andrew
    8 Dunn Brigg
    NG19 9RL Mansfield Woodhouse
    Nottinghamshire
    Amministratore
    8 Dunn Brigg
    NG19 9RL Mansfield Woodhouse
    Nottinghamshire
    EnglandBritish109020140001
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Amministratore
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish90170480001
    REED, Graeme John
    5 Woodhall Croft
    B92 8TP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    5 Woodhall Croft
    B92 8TP Solihull
    West Midlands
    British38899010002
    SAYERS, Steven
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    Amministratore
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    United KingdomBritish91113050001
    SCARLETT, Alistair
    Drum Cabaig
    Dervaig Tobermory
    PA75 6QR Isle Of Mull
    Argyll
    Amministratore
    Drum Cabaig
    Dervaig Tobermory
    PA75 6QR Isle Of Mull
    Argyll
    British88554460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AVONSIDE ROOFING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Avonside Group Services Limited
    The Courtyard, Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    England
    15 lug 2016
    The Courtyard, Green Lane
    OL10 2EX Heywood
    The Courtyard
    Lancashire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies House Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione6591179
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    AVONSIDE ROOFING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 ott 2015
    Consegnato il 19 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Timothy Hawkes
    Transazioni
    • 19 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 mag 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 feb 2015
    Consegnato il 18 feb 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 23 lug 2013
    Consegnato il 31 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Transazioni
    • 31 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 13 nov 2012
    Consegnato il 22 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The receivables meaning the debts and the payments instruments and all money, including without limitation, payments for work done and goods supplied see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Technical & General Guarantee Company Sa
    Transazioni
    • 22 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Morley
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 31 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Timothy Charles Hawkes
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 31 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Winter
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Keith Kershaw
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 31 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anthony Burke
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 31 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 mar 2006
    Consegnato il 11 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,045.30 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    All interest in the deposit account and all money from time to time in accordance with the rent deposit deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • David Montague Albermarle Bertie
    Transazioni
    • 11 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 nov 2005
    Consegnato il 16 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anthony Burke and Keith Kershaw
    Transazioni
    • 16 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 set 2003
    Consegnato il 15 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 15 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 24 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Factors Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 giu 1989
    Consegnato il 20 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital (excluding those mentioned above).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    AVONSIDE ROOFING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 set 2022Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0