BANDT GROUP LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBANDT GROUP LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02331328
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BANDT GROUP LTD.?

    • (7499) /

    Dove si trova BANDT GROUP LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    The Lexicon
    Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BANDT GROUP LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STAUFF GROUP LIMITED15 mag 198915 mag 1989
    INTERCEDE 644 LIMITED29 dic 198829 dic 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di BANDT GROUP LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per BANDT GROUP LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 ago 2010

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Mazars Llp Merchant Exchange Whitworth Street West Manchester M1 5WG England in data 23 feb 2010

    2 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Trevor Bradbury il 30 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Edward Badcock il 30 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Trevor Bradbury il 30 ott 2009

    1 pagineCH03

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 14 ago 2009

    LRESEX

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Conflict of intrest 22/09/2008
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BANDT GROUP LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    Segretario
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    British47884750003
    BADCOCK, Benjamin Edward
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish125575240001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish47884750003
    ASHFORTH, Phillip John
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    Segretario
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    British1311000004
    BRADBURY, Trevor
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    Segretario
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    British47884750003
    BUTLER, Richard John
    23a Wharf Hill
    SO23 9NQ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    23a Wharf Hill
    SO23 9NQ Winchester
    Hampshire
    British62923710002
    HARDING, Ian
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    Segretario
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    British35278190002
    LYNCH, Valerie Ann
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    Segretario
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    British68872030002
    ACTON, Peter
    Casa Neustra 92 Spinneyfield
    Moorgate
    S60 3LZ Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    Casa Neustra 92 Spinneyfield
    Moorgate
    S60 3LZ Rotherham
    South Yorkshire
    British45064920001
    ASHFORTH, Phillip John
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    Amministratore
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    United KingdomBritish1311000004
    CAMMOILE, Christopher
    35 Woodsetts Road
    Anston
    S31 7EQ Sheffield
    Yorkshire
    Amministratore
    35 Woodsetts Road
    Anston
    S31 7EQ Sheffield
    Yorkshire
    United KingdomBritish44734640001
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Amministratore
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    British49800090001
    FORD, William
    The Old School House
    4 Vine Court Road
    TN13 3UU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Old School House
    4 Vine Court Road
    TN13 3UU Sevenoaks
    Kent
    British47272920001
    HARDING, Ian
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    EnglandBritish35278190002
    HONEYBALL, Geoffrey Charles
    Trotter Down
    Reading Road
    RG27 9ED Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Trotter Down
    Reading Road
    RG27 9ED Hook
    Hampshire
    British66173870001
    LYNCH, Valerie Ann
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    Amministratore
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    EnglandBritish68872030002
    PARKES, David George
    Bowling Green House
    Evenley
    NN13 5SA Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bowling Green House
    Evenley
    NN13 5SA Brackley
    Northamptonshire
    British43077220001
    RAE, Douglas Keith
    Millview Farm
    Mark Lane Fulwood
    S10 4PY Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Millview Farm
    Mark Lane Fulwood
    S10 4PY Sheffield
    South Yorkshire
    British35386640001
    RUTTER, Richard Charles
    27 Clifton Road
    SO22 5BU Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    27 Clifton Road
    SO22 5BU Winchester
    Hampshire
    British72723760003
    SPOOR, Alan
    1 Bickley Avenue
    LE13 1UN Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    1 Bickley Avenue
    LE13 1UN Melton Mowbray
    Leicestershire
    British29639290001
    STEELE, William Lemmon
    1 Peterborough Avenue
    LE15 6EB Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    1 Peterborough Avenue
    LE15 6EB Oakham
    Leicestershire
    British15796150001
    WILSON, Richard Haigh
    Fairfield House
    Goose Hill Headley
    RG15 8AU Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Fairfield House
    Goose Hill Headley
    RG15 8AU Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish776180001

    BANDT GROUP LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture deed
    Creato il 20 mar 1998
    Consegnato il 25 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each "chargor" as defined therein to the chargee under or pursuant to the finance documents as defined
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust agreement
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the "obligors" as defined therein to the chargee under or pursuant to the finance documents as defined
    Brevi particolari
    The trust property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust agreement
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 28 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the operative documentsas defined
    Brevi particolari
    The trust property being the rights and proceeds as defined see form 395 ref M560C.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 28 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the operative documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including book debts (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BANDT GROUP LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 feb 2011Data di scioglimento
    14 ago 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert David Adamson
    Mazars House
    Gelderd Road
    LS27 7JN Gildersome
    Leeds
    Praticante
    Mazars House
    Gelderd Road
    LS27 7JN Gildersome
    Leeds
    Tim Alan Askham
    Mazars Llp
    Merchant Exchange
    M1 5WG Whitworth Street West
    Manchester
    Praticante
    Mazars Llp
    Merchant Exchange
    M1 5WG Whitworth Street West
    Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0