BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02332538 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED?
- (2211) /
- (2213) /
Dove si trova BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ARNFORM LIMITED | 03 gen 1989 | 03 gen 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 17 ott 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Elizabeth Jacobs come amministratore in data 16 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John William Burton come amministratore in data 31 ago 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Richard Wright il 19 ago 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Roger Graham Horton il 11 feb 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Emily Louise Martin come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Kerswell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Stephen Rigby il 05 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Adam Christopher Walker il 05 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 27 set 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per John William Burton il 11 ago 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Rachel Jacobs come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Gareth Richard Wright come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Emily Louise | Segretario | 2 Boutflower Road SW11 1RE London Ground Floor Flat United Kingdom | 160502510001 | |||||||
| WOOLLARD, Julie Louise | Segretario | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | British | 139159370002 | ||||||
| HORTON, Roger Graham | Amministratore | Mill Lane Shiplake RG9 3LY Henley-On-Thames Rivermead Oxfordshire United Kingdom | England | British | 56485660003 | |||||
| RIGBY, Peter Stephen | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 69164290007 | |||||
| WALKER, Adam Christopher | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | 129368430002 | |||||
| WRIGHT, Gareth Richard | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 131115190002 | |||||
| BRADLEY, Judy, Dr | Segretario | Weather Blades Fyfield OX13 5LN Oxon | British | 17734410001 | ||||||
| CALLABY, Andrea Mary | Segretario | 5 Thornton Drive CO4 5WB Colchester Essex | British | 70352690002 | ||||||
| PHILLIPS, Derek Malcolm | Segretario | 3 Holyrood House Church End South Leigh OX29 6US Witney Oxfordshire | British | 50358180003 | ||||||
| RICHMOND, Sonia Anna | Segretario | 8 Viscount Gardens KT14 6HE Byfleet Surrey | British | 118535490002 | ||||||
| THOMASSON, Jeffrey Scott | Segretario | 24 Webster Road SE16 4DF London | American | 64473410003 | ||||||
| BRADLEY, John Charles | Amministratore | Weatherblades Main Road, Fyfield OX13 5LN Abingdon Oxfordshire | British | 82149000001 | ||||||
| BURTON, John William | Amministratore | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London | United Kingdom | British | 113684810001 | |||||
| CONIBEAR, Jonathan James Garnham | Amministratore | The Grange Mill Street OX5 2SY Islip Oxon | United Kingdom | British | 258970950001 | |||||
| FOYE, Anthony Martin | Amministratore | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | United Kingdom | British | 99515780001 | |||||
| GILBERTSON, David Stuart | Amministratore | Casa Maria Spaniard's End Hampstead NW3 7JG London | United Kingdom | British | 10921820004 | |||||
| HAMES, Barry David, Dr | Amministratore | Plum Tree Cottage Church Street Whixley YO26 8AR York North Yorkshire | England | British | 103923320001 | |||||
| JACOBS, Rachel Elizabeth | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | United Kingdom | British | 92334500004 | |||||
| KERSWELL, Mark Henry | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | 82609620003 | |||||
| LEWIS, Giles Penfold | Amministratore | 112 Church Road Sandford On Thames OX4 4YB Oxford Oxfordshire | British | 22051950002 | ||||||
| OTLEY, Thomas Richard | Amministratore | Poulton House SN8 2LN Marlborough Wiltshire | British | 34814660001 | ||||||
| PHILLIPS, Derek Malcolm | Amministratore | 3 Holyrood House Church End South Leigh OX29 6US Witney Oxfordshire | England | British | 50358180003 | |||||
| RAY, Jonathan Paul, Dr | Amministratore | 42 Millwood End Long Hanborough OX29 8BY Witney Oxfordshire | United Kingdom | British | 82432370001 | |||||
| RICKWOOD, David, Dr | Amministratore | 24 Chalfont Road CO4 4NY Colchester Essex | British | 16335740001 | ||||||
| SMITH, David John | Amministratore | 10 South Close RG40 2DJ Wokingham Berkshire | England | British | 81852060001 | |||||
| THOMASSON, Jeffrey Scott | Amministratore | 24 Webster Road SE16 4DF London | England | American | 64473410003 | |||||
| WILSON, John | Amministratore | Three Sisters 9 Thame Road Long Crendon HP18 9AS Aylesbury Buckinghamshire | British | 45136910002 |
BIOS SCIENTIFIC PUBLISHERS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 23 mag 1997 Consegnato il 03 giu 1997 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 feb 1996 Consegnato il 29 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 nov 1991 Consegnato il 26 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 nov 1991 Consegnato il 27 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 nov 1991 Consegnato il 28 nov 1991 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0