YOLLES PARTNERSHIP LIMITED

YOLLES PARTNERSHIP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYOLLES PARTNERSHIP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02333623
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    • Altre attività di ingegneria (71129) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cottons Centre
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE YOLLES PARTNERSHIP LIMITED26 mar 199126 mar 1991
    M.S. YOLLES & PARTNERS (U.K.) LIMITED13 feb 198913 feb 1989
    COMENLY LIMITED10 gen 198910 gen 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 ago 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2020 al 30 set 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    13 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Tejender Singh Chaudhary il 25 mar 2019

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Brian R Shelton come amministratore in data 03 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan R. Shattock come amministratore in data 03 giu 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Guy Douglas come amministratore in data 03 giu 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Samuel James Hannis come amministratore in data 03 giu 2019

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Halcrow Group Limited come persona con controllo significativo il 25 mar 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Elms House 43 Brook Green London W6 7EF a Cottons Centre Cottons Lane London SE1 2QG in data 26 mar 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Samuel James Hannis il 03 lug 2017

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di James Christopher Rowntree come amministratore in data 21 giu 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHAUDHARY, Tejender Singh, Mr
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    Segretario
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    185594230001
    DOUGLAS, Guy
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish258025190001
    SHATTOCK, Jonathan R.
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TU Wokingham
    1180
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish259549880001
    BERGMANN, Andrew Peter Harry
    Suite 200
    163 Queen Street East
    M5A 1S1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Segretario
    Suite 200
    163 Queen Street East
    M5A 1S1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian10305120002
    MAIR, Kenneth
    8 Willowbank Gardens
    KT20 5DS Tadworth
    Surrey
    Segretario
    8 Willowbank Gardens
    KT20 5DS Tadworth
    Surrey
    British545490002
    PASUT, Mary Rose
    Suite 200
    163 Queen Street East
    Toronto
    Ontario M5a 151
    Canada
    Segretario
    Suite 200
    163 Queen Street East
    Toronto
    Ontario M5a 151
    Canada
    Canadian65525370001
    ROBERTS, Geoffrey
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Segretario
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    172548610001
    BERGMANN, Andrew Peter Harry
    Suite 200
    163 Queen Street East
    M5A 1S1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    Suite 200
    163 Queen Street East
    M5A 1S1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Canadian10305120002
    BERGMANN, Roland
    Suite 200
    163 Queen St East
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5a 1s1
    Canada
    Amministratore
    Suite 200
    163 Queen St East
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5a 1s1
    Canada
    Canadian10305150001
    COATES, Alasdair John Fraser
    Endeavour House
    Forder Way
    PE7 8GX Hampton
    Halcrow Group Ltd
    Peterborough
    United Kingdom
    Amministratore
    Endeavour House
    Forder Way
    PE7 8GX Hampton
    Halcrow Group Ltd
    Peterborough
    United Kingdom
    United KingdomBritish119145310001
    HANNIS, Samuel James, Mr
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Amministratore
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194337810003
    HARRINGTON, Sarah Elizabeth
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    England
    England
    Amministratore
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    England
    England
    United KingdomBritish172293460001
    KERR, David John
    Fielding Road
    W4 1HP London
    11
    Amministratore
    Fielding Road
    W4 1HP London
    11
    EnglandBritish22568600002
    MAIR, Kenneth
    8 Willowbank Gardens
    KT20 5DS Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    8 Willowbank Gardens
    KT20 5DS Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish545490002
    MAN, Michael Oswald
    Suite 200
    163 Queen St East
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5a 1s1
    Canada
    Amministratore
    Suite 200
    163 Queen St East
    FOREIGN Toronto
    Ontario M5a 1s1
    Canada
    Canadian10305130001
    MAPPLEBECK, Rupert Neil
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Amministratore
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    EnglandBritish167746860001
    MATHEWS, Steven Carrol
    South Jamaica Street
    80112 Englewood
    9191
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    South Jamaica Street
    80112 Englewood
    9191
    Colorado
    Usa
    UsAmerican173444500001
    PASUT, Mary Rose
    Suite 200
    163 Queen Street East
    Toronto
    Ontario M5a 151
    Canada
    Amministratore
    Suite 200
    163 Queen Street East
    Toronto
    Ontario M5a 151
    Canada
    Canadian65525370001
    PRAGER, Michael Edward
    Hilltop
    Rabley Heath
    AL6 9UB Welwyn
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hilltop
    Rabley Heath
    AL6 9UB Welwyn
    Hertfordshire
    EnglandBritish29163620001
    ROWNTREE, James Christopher
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    Amministratore
    43 Brook Green
    W6 7EF London
    Elms House
    United Kingdom
    United KingdomBritish165022490001
    SAFFER, Alan
    Vineyard House
    44 Brook Green
    W6 7BY London
    C/O Halcrow
    United Kingdom
    Amministratore
    Vineyard House
    44 Brook Green
    W6 7BY London
    C/O Halcrow
    United Kingdom
    EnglandBritish72309130002
    SHELTON, Brian R
    Brook Green
    W6 7EF London
    43
    England
    England
    Amministratore
    Brook Green
    W6 7EF London
    43
    England
    England
    United StatesAmerican178299300002
    STANLEY, Heather Mary
    24 Bromley Lane
    BR7 6LE Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    24 Bromley Lane
    BR7 6LE Chislehurst
    Kent
    British40228900001
    THIEMANN, Peter Martin Richard
    9 Highfield Road
    KT12 2RJ Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    9 Highfield Road
    KT12 2RJ Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritish68100220002
    YOLLES, Norden Saul
    67 Binscarth Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M4w 1y3
    Canada
    Amministratore
    67 Binscarth Road
    FOREIGN Toronto
    Ontario M4w 1y3
    Canada
    Canadian10305140001
    ZUCCHI, Paul Aurelius
    115 Roxborough Drive
    M4W 1X5 Toronto
    Ontario
    Amministratore
    115 Roxborough Drive
    M4W 1X5 Toronto
    Ontario
    Canadian42307680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di YOLLES PARTNERSHIP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Cottons Lane
    SE1 2QG London
    Cottons Centre
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3415971
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    YOLLES PARTNERSHIP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 dic 2009
    Consegnato il 19 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor or member of the group to the finance parties and from the company or any member of the group to any of the external ancillary lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 19 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 dic 2006
    Consegnato il 09 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 09 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2001
    Consegnato il 20 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Underlease
    Creato il 05 nov 1997
    Consegnato il 15 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the performance of the company's obligations under the lease
    Brevi particolari
    The charge and all it's interest in the account which is a seperate designated deposit account see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for the Enviroment
    Transazioni
    • 15 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0