ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02337981 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | No 1 Dorset Street SO15 2DP Southampton Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HOVEVET LIMITED | 24 gen 1989 | 24 gen 1989 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Pixham End Dorking Surrey RH4 1QA a No 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP in data 11 ago 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr David Rowley Rose come amministratore in data 07 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Carr come amministratore in data 08 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Clair Louise Marshall come amministratore in data 07 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Charles Paykel come amministratore in data 08 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Conor Martin O'neill come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Stephen Moss come amministratore in data 07 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Secretariat Friends Life 2nd Floor, One New Change London England EC4M 9EF England a St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Conor Martin O'neill come amministratore in data 31 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Charles Paykel come amministratore in data 31 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robin Duncan Smith come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Potkins come amministratore in data 31 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Andrew David Carr come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIENDS LIFE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | RH4 1QA Dorking Pixham End Surrey United Kingdom |
| 168876640001 | ||||||||||
| MARSHALL, Clair Louise | Amministratore | YO90 1WR York Wellington Row United Kingdom | United Kingdom | British | 200178890001 | |||||||||
| ROSE, David Rowley | Amministratore | 1 Undershaft EC3P 3DQ London St Helen's United Kingdom | United Kingdom | British | 89567200001 | |||||||||
| ELLIS, Robert Gordon | Segretario | Severals Oakwood PO18 9AL Chichester West Sussex | British | 33165610001 | ||||||||||
| HODGE, Blackwood Samuel | Segretario | 87 Westmoreland Road BR2 0TQ Bromley Kent | British | 2766370001 | ||||||||||
| MONGER, Diana | Segretario | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | 148096770001 | |||||||||||
| SWEETLAND, Brian William | Segretario | Wynstone Comptons Brow Lane RH13 6BX Horsham West Sussex | British | 11156930002 | ||||||||||
| BLACK, James Masson | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 172334880001 | |||||||||
| BOURKE, Evelyn Brigid | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | Irish,British | 247998930001 | |||||||||
| BROOKS, Anthony Michael | Amministratore | High Trees 104 Gregories Road HP9 1HN Beaconsfield Buckinghamshire | British | 1466060001 | ||||||||||
| CARR, Andrew David | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 182546040001 | |||||||||
| DOUBBLE, David John Meredith | Amministratore | 28 Belvedere Close TW11 0NT Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 6606840001 | |||||||||
| ELLIS, Robert Gordon | Amministratore | Severals Oakwood PO18 9AL Chichester West Sussex | England | British | 33165610001 | |||||||||
| HEINTZ, Jeffrey William | Amministratore | 20 Mallord Street SW3 6DU London | American | 51800230002 | ||||||||||
| HODGE, Blackwood Samuel | Amministratore | 87 Westmoreland Road BR2 0TQ Bromley Kent | British | 2766370001 | ||||||||||
| J'AFARI-PAK, Lindsay Clare | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 155016370001 | |||||||||
| JONES, Peter Derek | Amministratore | 13 Vincent Square SW1P 2LX London | United Kingdom | British | 6775340001 | |||||||||
| KARPER, Stephen James | Amministratore | 69 Kensington Court Kensington W8 5DS London | Usa | 26363470001 | ||||||||||
| KEMPNER, Nigel Justin | Amministratore | Bix Field Bix RG9 6BW Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 170036770001 | |||||||||
| MACLACHLAN, Alexander | Amministratore | Deerleap House Deerleap Road RH4 3LE Westcott Surrey | United Kingdom | British | 53315450001 | |||||||||
| MAGUIRE, James Joseph | Amministratore | 4 Sunnyside Place Wimbledon SW19 4SJ London | British | 26363490001 | ||||||||||
| MONGER, Diana | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 4768870003 | |||||||||
| MOSS, Jonathan Stephen | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 172135620001 | |||||||||
| MUSGRAVE, Stephen Howard Rhodes | Amministratore | 4 Haverfield Gardens Kew TW9 3DD Richmond Surrey | United Kingdom | British | 6981200001 | |||||||||
| NICHOLS, James Andrew | Amministratore | 63 Abingdon Road Kennsington W8 6AN London | British | 316610002 | ||||||||||
| O'NEILL, Conor Martin | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 194342160001 | |||||||||
| PAYKEL, Jonathan Charles | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 194342300001 | |||||||||
| POTKINS, Martin | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | United Kingdom | British | 182195910001 | |||||||||
| SILVESTER, Peter | Amministratore | Dulverton, Priorswood Compton GU3 1DS Guildford Surrey | England | British | 5067740001 | |||||||||
| SMITH, Robin Duncan | Amministratore | Pixham End Dorking RH4 1QA Surrey | England | British | 82532400001 | |||||||||
| SWEETLAND, Brian William | Amministratore | Wynstone Comptons Brow Lane RH13 6BX Horsham West Sussex | Uk | British | 11156930002 | |||||||||
| WHIFFIN, Roger Michael | Amministratore | 8 Clandon Road GU1 2DR Guildford Surrey | British | 11156910001 |
ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second floating charge | Creato il 19 ago 1992 Consegnato il 08 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the facility letter and the "security documents" (as defined) | |
Brevi particolari And rights (see doc ref M90 for full details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 13 dic 1989 Consegnato il 27 dic 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the revolving loan agreement dated 13-12-89. | |
Brevi particolari First floating charge over (see doc M399 - ref M320 for full details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 dic 1989 Consegnato il 21 dic 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any of the borrowers (as defined in the loan agreement) to citibank N.A. as agent and trustee for each fo the beneficiaries as defined in the charge on any account whatsoever pursuant to a revolving loan agreement of even date and a group guarantee dated 13-12-89. | |
Brevi particolari By way of legal charge the properties as listed on schedule b on form 395. by way of assignment all the chargers right, title and interest in each and every policy of insurance related to the mortgaged property together with all monies payable under each and every policy. The benefit of all covenants and rights concerning the property (for full details of listed properties see schedule b, doc M31). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental legal charge | Creato il 11 set 1989 Consegnato il 12 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal charge dated 8-3-89 and this charge and a supplemental loan agreement dated 11.9.89. | |
Brevi particolari F/H property k/a 14 james street, london W1. Title no. 245753. rental sums as defined in teh security, full benefit of all rights and remedies. (For full details see doc M171). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 08 mar 1989 Consegnato il 16 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 7.3.89 | |
Brevi particolari All f/h & l/h property as listed on schedule attached to doc M39 tog with all buildings & fixtures plant & machinery all moneys standing to the accounts of the company with the bank floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill please see doc M3 for details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ST CHRISTOPHER'S PLACE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0