MKD HOLDINGS LIMITED

MKD HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMKD HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02340362
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MKD HOLDINGS LIMITED?

    • (3614) /
    • (5244) /

    Dove si trova MKD HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kroll
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MKD HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOBEN KITCHENS DIRECT LIMITED04 mag 198904 mag 1989
    ALNERY NO. 826 LIMITED27 gen 198927 gen 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di MKD HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per MKD HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 04 ott 2008

    14 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 ott 2008

    15 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Dimissioni di un amministratore

    9 pagine2.38B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    15 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività

    20 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    44 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    24 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    25 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di MKD HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURPHY, John
    Eagles View
    46 Burford Lane
    WA13 0SH Lymm
    Cheshire
    Segretario
    Eagles View
    46 Burford Lane
    WA13 0SH Lymm
    Cheshire
    British28789400004
    BENNETT, Yvonne Elizabeth
    Farm View
    Long Reach
    KT24 6LZ West Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Farm View
    Long Reach
    KT24 6LZ West Horsley
    Surrey
    British92978920001
    GAASTRA, Stephen
    Long Meadow House Mill Lane
    CB25 0NF Swaffham Bulbeck
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Long Meadow House Mill Lane
    CB25 0NF Swaffham Bulbeck
    Cambridgeshire
    EnglandBritish96778910001
    GOODING, Christopher Thomas
    4 Hook Hill Park
    GU22 0PX Woking
    Surrey
    Amministratore
    4 Hook Hill Park
    GU22 0PX Woking
    Surrey
    British101921460001
    GOSAL, Kulvant Singh
    3 Church House
    Manor Lane
    CV35 0JT Kineton
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Church House
    Manor Lane
    CV35 0JT Kineton
    Warwickshire
    British101921440001
    POVEY, Roy
    10 Westbourne Grove
    M33 6RD Sale
    Cheshire
    Amministratore
    10 Westbourne Grove
    M33 6RD Sale
    Cheshire
    EnglandBritish254100460001
    SLOWEY, Neil Patrick
    7 Newby Close
    BL9 9GG Bury
    Lancashire
    Amministratore
    7 Newby Close
    BL9 9GG Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish101731390001
    VICENTE, Joaquim Antonio Clara
    112 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    112 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandPortuguese104002590002
    LEWIS, Ashley Martin
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    Segretario
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    British136948910001
    BOLER, Stephen Eckersley
    Wrenshot Wrenshot Lane
    High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Wrenshot Wrenshot Lane
    High Legh
    WA16 6PG Knutsford
    Cheshire
    British19357700001
    CARR, Anthony
    27 Rutland Road
    PR8 6PB Southport
    Merseyside
    Amministratore
    27 Rutland Road
    PR8 6PB Southport
    Merseyside
    British14170250001
    COTTER, Stephen Anthony
    Bracken
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    Bracken
    Plantation Road
    LU7 3HT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritish78750100001
    DILWORTH, Eric Alain
    Cockers Farm House
    Long Lane Limbrick
    PR6 9EE Chorley
    Amministratore
    Cockers Farm House
    Long Lane Limbrick
    PR6 9EE Chorley
    British87217710001
    HENDER, Thomas
    Wheatmans Cottage
    2 Lapworth Street
    BG5 5ES Lowsonford
    Warwickshire
    Amministratore
    Wheatmans Cottage
    2 Lapworth Street
    BG5 5ES Lowsonford
    Warwickshire
    British39104570002
    HILL, Derek William
    53 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    53 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British105971130001
    HILL, Philip Nigel
    19 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    19 Whitland Avenue
    BL1 5FB Bolton
    Lancashire
    British66695480001
    HOLDEN, Gavin
    The Red House
    Lower Street
    TN33 9ED Ninfield Battle
    East Sussex
    Amministratore
    The Red House
    Lower Street
    TN33 9ED Ninfield Battle
    East Sussex
    British101921430001
    LEWIS, Ashley Martin
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    Amministratore
    Bollinway
    Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    The Spinney
    Cheshire
    EnglandBritish136948910001
    LYNSKEY, Peter John
    Fairleigh Hinderton Lane
    Neston
    CH64 9QA South Wirral
    Cheshire
    Amministratore
    Fairleigh Hinderton Lane
    Neston
    CH64 9QA South Wirral
    Cheshire
    United KingdomBritish25563190001
    MURPHY, John
    25 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    25 Grammar School Road
    WA13 0BQ Lymm
    Cheshire
    British28789400001
    MURRAY, William John
    Annells
    Cowfold Lane
    RG27 9BP Rotherwick
    Hampshire
    Amministratore
    Annells
    Cowfold Lane
    RG27 9BP Rotherwick
    Hampshire
    British34787230004
    SAMSON, Harvey Jack
    1 Acacia Drive
    Hale
    WA15 8QZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    1 Acacia Drive
    Hale
    WA15 8QZ Altrincham
    Cheshire
    British3650740001
    STANWAY, Andrew David
    Beechcroft House
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Beechcroft House
    Henley Road
    SL7 2BZ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom British 31199160002
    WATTS, Stephen John
    455 Cockfosters Road
    EN4 0JT Hadleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    455 Cockfosters Road
    EN4 0JT Hadleywood
    Hertfordshire
    British37062200001
    WEST, Geoffrey Arthur
    31 Vale Close
    Heaton Norris
    SK4 5DS Stockport
    Amministratore
    31 Vale Close
    Heaton Norris
    SK4 5DS Stockport
    British23989730001
    WHITE, Joseph Kenneth
    Rushafield Farm Green Lane
    SK14 3BD Hyde
    Cheshire
    Amministratore
    Rushafield Farm Green Lane
    SK14 3BD Hyde
    Cheshire
    EnglandBritish23989740001
    WILSON, Jenny Charles
    8 Rochfield Avenue
    M25 7PS Whitefield
    Manchester
    Amministratore
    8 Rochfield Avenue
    M25 7PS Whitefield
    Manchester
    British23989770001

    MKD HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 gen 2004
    Consegnato il 13 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h premises at cornbrook 2 brindley road old trafford manchester t/n's GM355091, GM356519, GM356520 and GM371063. The plot of land lying to the north west of chester road old trafford manchester t/n GM289483. Plot 3 springvale on the west side of black county route bilston t/n GM647649 for details of further property charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canven (C.I.) Limited (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 07 ago 2003
    Consegnato il 09 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to any security beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H and l/h premises at cornbrook, 2 brindley road, old trafford, manchester, M16 9HQ t/nos GM355091, GM356519, GM356520 and GM371063, the plot of land lying to the north west of chester road, old trafford, manchester t/n GM289483, plot 3, springvale on the west side of black county route, bilston t/n GM647649 (refer to form 395 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canven (C.I.) Limited (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 set 2001
    Consegnato il 19 set 2001
    In corso
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined),or any of them,under the banking documents (as defined)
    Brevi particolari
    L/Hold land lying to the north west of chester rd,old trafford,manchester; t/no gm 289483. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee (the security trustee) and the security beneficiaries (as defined) or any of them under the banking documents (as defined)
    Brevi particolari
    F/H and l/h land k/a cornbrook 2 brindley road old trafford manchester t/nos. GM355091, GM356519, GM356520 and GM371063.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession (to a composite guarantee and debenture dated 10TH august 2000)
    Creato il 30 ott 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee (the security trustee) and the security beneficiaries (as defined) or any of them under the banking documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 02 ago 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 ott 1998
    Consegnato il 14 ott 1998
    In corso
    Importo garantito
    £1,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    £1,500.
    Persone aventi diritto
    • Enfranchise 226 Limited
    Transazioni
    • 14 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 19 lug 1995
    Consegnato il 22 lug 1995
    In corso
    Importo garantito
    The whole or any part of the rents reserved by a lease or any money payable pursuant to the lease or any expense incurred by the landlord in consequence of any failure by the tenant to observe and perform the covenants and obligations of and the conditions binding the tenant contained in the lease
    Brevi particolari
    £1,500 and accrued interest.
    Persone aventi diritto
    • Highcross Developments Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1994
    Consegnato il 16 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a cornbrook, 2 brindley road, old trafford, manchester t/nos: GM355091, GM356520, GM371963, GM356519,GM464482 and GM450626. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 nov 1994
    Consegnato il 06 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the chargee under the stock documents as defined in this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcr Any of Themstockholders (As Defined) and the Stockholders Oas Agent and Trustee for Itself and Each of The
    Transazioni
    • 06 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guaranee and debenture
    Creato il 18 nov 1994
    Consegnato il 21 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 19 apr 1994
    Consegnato il 20 apr 1994
    Data dello strumento di garanzia 19 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Adt Group PLC and Adt Trustees Limited
    Transazioni
    • 20 apr 1994Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 25 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 apr 1994
    Consegnato il 25 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture registered pursuant to an order of the court dated 29TH september 1992
    Creato il 20 lug 1992
    Consegnato il 10 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See doc M395 ref M371 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • M K D Group Limited
    Transazioni
    • 10 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 04 set 1991
    Consegnato il 18 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £164,530.83 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All its right title & interest in and to all sums payable under the insurance (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 18 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of deposit
    Creato il 27 set 1990
    Consegnato il 08 ott 1990
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a lease dated 25/3/87 and this deed of deposit
    Brevi particolari
    The sum of £7,500.
    Persone aventi diritto
    • Fiabrook Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    Rent deposit deed.
    Creato il 02 nov 1989
    Consegnato il 09 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 2.11.89
    Brevi particolari
    £5,750.00.
    Persone aventi diritto
    • Midland City Properties Limited.
    Transazioni
    • 09 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1989
    Consegnato il 20 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Orama mill, whitworth rochdale, gr. Manchester together with the goodwill of the business undertaken at the property.
    Persone aventi diritto
    • First National Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 nov 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mag 1989
    Consegnato il 02 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MKD HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 apr 2007Inizio dell'amministrazione
    04 ott 2008Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Charles Peter Holder
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Robert Alexander Henry Maxwell
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praticante
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0