TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED

TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02345011
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASHURST PARK INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED23 gen 199123 gen 1991
    SCATSOUTH A51 LIMITED08 feb 198908 feb 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Simon Gordon come amministratore in data 02 nov 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Spire Healthcare Limited come amministratore in data 02 nov 2015

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Robert Roger come amministratore in data 02 nov 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Gordon il 01 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Roger il 01 giu 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Roger il 01 lug 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Gordon il 01 lug 2015

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2015

    Stato del capitale al 09 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 feb 2014

    Stato del capitale al 11 feb 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 120 Holborn London EC1N 2TD* in data 12 dic 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Francis Toner il 23 ago 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 08 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Jean De Gorter come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Segretario
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    British100270040001
    TONER, Daniel Francis
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish100270040002
    SPIRE HEALTHCARE LIMITED
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1522532
    202359590001
    MORRIS, David Richard
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    22 Lee Lane East
    Horsforth
    LS18 5RE Leeds
    West Yorkshire
    British64514410001
    PRESTON, David James
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    Segretario
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    British46551430003
    PRESTON, David James
    5 Cock Robin Cottages
    Croston
    PR5 7HH Preston
    Segretario
    5 Cock Robin Cottages
    Croston
    PR5 7HH Preston
    British46551430001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Segretario
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BARKER, Hilary Jane
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    Amministratore
    Flat B22 Herbal Hill Gardens
    9 Herbal Hill
    EC1R 5EJ London
    British62838010001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Dower House
    Westmill
    SG9 9LY Buntingford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105797560001
    BURNS, Robert Ian
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Netherfield Road
    AL5 2AG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish36584260002
    CHADWICK, Bernard Keith
    Willow Glen Dowbridge
    Kirkham
    PR4 2YL Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Willow Glen Dowbridge
    Kirkham
    PR4 2YL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish3632310001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DE GORTER, Jean Jacques, Dr
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    United KingdomFrench128865640001
    DUGDALE, Michael Ian
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    Amministratore
    29 Magnolia Dene
    HP15 7QE Hazlemere
    Buckinghamshire
    British79570840001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    FOZARD, Ian
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Brewhouse
    8a Waterside
    HG5 9AZ Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish21934910001
    GORDON, Simon
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish162037020001
    GRAY, Duncan Archibald
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    Amministratore
    51 Exchange Building
    132 Commercial Street
    E1 6NG London
    EnglandBritish68845270002
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    HEMMING, Eric Rodney
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Amministratore
    The Elms
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British84030950001
    HOLDEN, Dean Allan
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Spring House
    Spring Hill Fordcombe
    TN3 0SE Tunbridge Wells
    Kent
    British32671980002
    HOLLINGSWORTH, Clare Margaret
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    Amministratore
    House Farm
    Crowhurst Lane Crowhurst
    RH7 6LR Lingfield
    Mansion
    Surrey
    United KingdomBritish62952630002
    JONES, Richard James Edward
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    Amministratore
    Holborn
    EC1N 2TD London
    120
    EnglandBritish133019680001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Amministratore
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Raymond
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    British56146040001
    LEA, Edward William
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    British28018450003
    PRESTON, David James
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    Amministratore
    4 Victoria Mansions
    Navigation Way Ashton On Ribble
    PR2 2YX Preston
    Lancashire
    British46551430003
    ROGER, Robert
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    Amministratore
    Dorset Rise
    EC4Y 8EN London
    3
    United KingdomBritish151959030001
    SARSFIELD, Vincent Gerard
    Little Lowes Fold Heath Lane
    Lowton
    WA3 2SJ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Little Lowes Fold Heath Lane
    Lowton
    WA3 2SJ Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish5491860001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001

    TUNBRIDGE WELLS INDEPENDENT HOSPITAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 22 ott 2008
    Consegnato il 29 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transazioni
    • 29 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2002
    Consegnato il 31 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited as Borrower Security Trustee (as Defined Therein)
    Transazioni
    • 31 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 lug 1996
    Consegnato il 20 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tunbridge wells independent hospital ashurst park fordcombe tunbridge wells t/no K709645 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 mar 1992
    Consegnato il 25 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 25 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 dic 1991
    Consegnato il 08 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof, fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts andthe benefits of any licences l/h property comprised in title no k 709645 being a lease of ashurst park independent hospital fordcombe road tunbridge wells kent from ibh limited (1) to ashurst park independent hospital limited (2) dated 21/8/91.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 ago 1991
    Consegnato il 10 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h property, tunbridge wells independent hospital tunbridge wells kent. Including all fixtures fittings other than trade fixtures and fittings plant and machinery. (See form 395 and continuation sheet for full details document M114). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 lug 1991
    Consegnato il 09 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein to the chargee on any account
    Brevi particolari
    (See for 395 document M13C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 1991
    Consegnato il 24 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    500000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of charge.
    Brevi particolari
    Land at ashurst park fordcombe county of kent being part of land comprised in t/no. K535622.
    Persone aventi diritto
    • Ibh Limited.
    Transazioni
    • 24 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 1990
    Consegnato il 31 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at ashurst park near fordcombe road, fordcombe in the company of kent title no K535622. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0