ISPAL SERVICES LIMITED

ISPAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàISPAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02346113
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ISPAL SERVICES LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova ISPAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sovereign House 212-224 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8HQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ISPAL SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ILAM SERVICES LIMITED28 giu 198928 giu 1989
    DABIX LIMITED10 feb 198910 feb 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di ISPAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ISPAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Patrick Corcoran come amministratore in data 30 set 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr. Paul Andrew John Cluett come amministratore in data 30 set 2011

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ago 2011

    Stato del capitale al 17 ago 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 28 feb 2011 al 31 mar 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Bush Lane Secretaries Limited il 23 lug 2010

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 28 feb 2010

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Jeffery Kendall il 23 lug 2010

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Steven Franks come amministratore

    1 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ilam services LIMITED\certificate issued on 17/02/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 14 dic 2009

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 28 feb 2009

    9 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 29 feb 2008

    11 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 28 feb 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di ISPAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUSH LANE SECRETARIES LIMITED
    212-224 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8HQ London
    Sovereign House
    United Kingdom
    Segretario
    212-224 Shaftesbury Avenue
    WC2H 8HQ London
    Sovereign House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00833059
    128627560001
    CLUETT, Paul Andrew John
    3 Oakwood Drive
    LE11 3QF Loughborough
    Sportpark Loughborough University
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    3 Oakwood Drive
    LE11 3QF Loughborough
    Sportpark Loughborough University
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish137390280001
    CORCORAN, Patrick
    3 Oakwood Drive
    LE11 3QF Loughborough
    Sportpark Loughborough University
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    3 Oakwood Drive
    LE11 3QF Loughborough
    Sportpark Loughborough University
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomIrish115395560001
    KENDALL, Ian Jeffrey, Mr.
    The Beeches
    Sands House Sands Lane
    WF14 8HJ Mirfield
    Amministratore
    The Beeches
    Sands House Sands Lane
    WF14 8HJ Mirfield
    United KingdomBritish90755880001
    FRANKS, Steven Christopher
    39 Mayfair Grove
    Priorslee
    TF2 9GJ Telford
    Shropshire
    Segretario
    39 Mayfair Grove
    Priorslee
    TF2 9GJ Telford
    Shropshire
    British92058880001
    LANGFORD, John Anthony
    2 Merryman Drive
    RG11 6TW Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    2 Merryman Drive
    RG11 6TW Crowthorne
    Berkshire
    United Kingdom24317490001
    SMITH, Alan
    4 Crispin Close
    Caversham
    RG4 7JS Reading
    Berkshire
    Segretario
    4 Crispin Close
    Caversham
    RG4 7JS Reading
    Berkshire
    British13953770001
    STRANGE, Brian Antony
    5 Robert Sparrow Gardens
    Crowmarsh
    OX10 8DQ Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    5 Robert Sparrow Gardens
    Crowmarsh
    OX10 8DQ Wallingford
    Oxfordshire
    British73957020002
    BATES, Gordon Francis
    12 Mickleby Close
    Nunthorpe
    TS7 0QX Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    12 Mickleby Close
    Nunthorpe
    TS7 0QX Middlesbrough
    Cleveland
    EnglandBritish43815580001
    BINNEY, Peter
    36 Monarch Drive
    WR2 6EP Worcester
    Hereford And Worcestershire
    Amministratore
    36 Monarch Drive
    WR2 6EP Worcester
    Hereford And Worcestershire
    British46974050001
    CORCORAN, Paddy
    3 Cottage Farm
    TS19 7HW Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    3 Cottage Farm
    TS19 7HW Stockton On Tees
    Cleveland
    Irish76769100002
    CRONERY, Leonard John
    Higher Pengelly
    PL30 4HR Bodmin
    Cornwall
    Amministratore
    Higher Pengelly
    PL30 4HR Bodmin
    Cornwall
    British82883530001
    FRANKS, Steven Christopher
    39 Mayfair Grove
    Priorslee
    TF2 9GJ Telford
    Shropshire
    Amministratore
    39 Mayfair Grove
    Priorslee
    TF2 9GJ Telford
    Shropshire
    United KingdomBritish92058880001
    FREEMAN, Alan
    12 Butt Lane
    LE10 1LD Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    12 Butt Lane
    LE10 1LD Hinckley
    Leicestershire
    British59601550001
    FULFORD, Michael Allen
    18 Curlew Hill
    NE61 3SH Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    18 Curlew Hill
    NE61 3SH Morpeth
    Northumberland
    British13953780001
    FULFORD, Michael Allen
    18 Curlew Hill
    NE61 3SH Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    18 Curlew Hill
    NE61 3SH Morpeth
    Northumberland
    British13953780001
    MORRALL, Peter Edward
    79 Dowthorpe Hill
    Earls Barton
    NN6 0PY Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    79 Dowthorpe Hill
    Earls Barton
    NN6 0PY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish29314840001
    MORRALL, Peter Edward
    79 Dowthorpe Hill
    Earls Barton
    NN6 0PY Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    79 Dowthorpe Hill
    Earls Barton
    NN6 0PY Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish29314840001
    ONIONS, Norman Barry
    43 Fairbanks Walk
    Swynnerton
    ST15 0PF Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    43 Fairbanks Walk
    Swynnerton
    ST15 0PF Stone
    Staffordshire
    British13953800001
    PARRATT, Phyllis Catherine
    64 Arundel Road
    Woodley
    RG5 4JT Reading
    Berkshire
    Amministratore
    64 Arundel Road
    Woodley
    RG5 4JT Reading
    Berkshire
    British13953810001
    ROURKE, John
    114 Broom Lane
    S60 3EP Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    114 Broom Lane
    S60 3EP Rotherham
    South Yorkshire
    British13953790001
    SMITH, Alan
    4 Crispin Close
    Caversham
    RG4 7JS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    4 Crispin Close
    Caversham
    RG4 7JS Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish13953770001
    SMITH, Stephen Harry Francis
    34 The Crescent
    Mortimer Common
    RG7 3RU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    34 The Crescent
    Mortimer Common
    RG7 3RU Reading
    Berkshire
    British53701350001
    STAYTE, Susan
    4 Chiltern Walk
    Pangbourne
    RG8 7LE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    4 Chiltern Walk
    Pangbourne
    RG8 7LE Reading
    Berkshire
    British67440980001
    STRANGE, Brian Antony
    5 Robert Sparrow Gardens
    Crowmarsh
    OX10 8DQ Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Robert Sparrow Gardens
    Crowmarsh
    OX10 8DQ Wallingford
    Oxfordshire
    British73957020002

    ISPAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 gen 2004
    Consegnato il 10 feb 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0