HUNTSON HOLDINGS LIMITED

HUNTSON HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUNTSON HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02346361
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio di autovetture usate (45112) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli (45320) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita, manutenzione e riparazione di motocicli e relativi pezzi e accessori (45400) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HUNTSON HOLDINGS PLC13 feb 198913 feb 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 lug 2020

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 apr 2019 al 28 apr 2019

    3 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2019 al 29 apr 2019

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 29 apr 2018

    27 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 023463610045, creata il 18 mar 2019

    7 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 023463610043, creata il 06 dic 2017

    31 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 023463610044, creata il 06 dic 2017

    34 pagineMR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2017

    31 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 41 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOWEATHER, Shaun
    Capitol Park
    Omega Boulevard Thorne
    DN8 5TX Doncaster
    Stoneacre
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Capitol Park
    Omega Boulevard Thorne
    DN8 5TX Doncaster
    Stoneacre
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishNone121437520001
    TEATUM, Richard Stephen
    Capitol Park
    Omega Boulevard Thorne
    DN8 5TX Doncaster
    Stoneacre
    South Yorkshire
    Amministratore
    Capitol Park
    Omega Boulevard Thorne
    DN8 5TX Doncaster
    Stoneacre
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director9538630003
    WOOD, Nigel Peter
    Capitol Park
    Omega Boulevard Thorne
    DN8 5TX Doncaster
    Stoneacre
    South Yorkshire
    Amministratore
    Capitol Park
    Omega Boulevard Thorne
    DN8 5TX Doncaster
    Stoneacre
    South Yorkshire
    EnglandBritishCompany Accountant149060500001
    CATTEE, Anna Elizabeth
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    Segretario
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    188311760001
    PRITCHARD, Judith Ann
    7 Deepwell View
    Halfway
    S20 4SP Sheffield
    Segretario
    7 Deepwell View
    Halfway
    S20 4SP Sheffield
    British2936770002
    SHIERS, Rodney Alan
    The Headlands East Bank
    Winster
    DE4 2DS Matlock
    Derbyshire
    Segretario
    The Headlands East Bank
    Winster
    DE4 2DS Matlock
    Derbyshire
    British1310960002
    CORDIN, Anthony Frederick
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    Amministratore
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    EnglandBritishGroup Operations Director81701640001
    PRIESTNALL, David Kenneth
    2 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    2 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishMotor Dealer3263350001
    PRIESTNALL, Simon Richard
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    Amministratore
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    United KingdomBritishDirector127017340001
    PRIESTNALL, Stephen David
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    Amministratore
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    EnglandBritishCorporate Development Director201598370001
    PRIESTNALL, Susan Elizabeth
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    Amministratore
    Brimington Road North
    Chesterfield
    S41 9AJ Derbyshire
    EnglandBritishMotor Dealer2936790001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HUNTSON HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Omega Boulevard
    Thorne
    DN8 5TX Thorne
    Stoneacre
    England
    06 apr 2016
    Omega Boulevard
    Thorne
    DN8 5TX Thorne
    Stoneacre
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09640998
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    HUNTSON HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 mar 2019
    Consegnato il 18 mar 2019
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 dic 2017
    Consegnato il 06 dic 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 dic 2017
    Consegnato il 06 dic 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2011
    Consegnato il 15 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at meadow lane, nottingham t/no NT291386 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 giu 2010
    Consegnato il 30 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santander Consumer (UK) PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge on vehicle stocks
    Creato il 23 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge all new and used motor vehicles, fixed charge all proceeds of sale all insurance monies, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Volvo Car Finance Limited
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2009
    Consegnato il 26 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Volvo Car Finance
    Transazioni
    • 26 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 lug 2007
    Consegnato il 20 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Autoworld brimington road north chesterfield derbyshire together with all buildings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fiat Auto Financial Services (Wholesale) Limited
    Transazioni
    • 20 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 05 apr 2006
    Consegnato il 22 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Garage premises at savile street sheffield south yorkshire together with all buildings fixtures plant machinery fittings and apparatus whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the mortgaged property.
    Persone aventi diritto
    • Fiat Auto Financial Services (Wholesale) Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 22 apr 2004
    Consegnato il 28 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of brimington road north whittington monk chesterfield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 2002
    Consegnato il 17 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Garage premises at savile st,sheffield,south yorkshire with all buildings,fixtures,plant,machinery,fittings and apparatus whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Fiat Auto (UK) Limited
    Transazioni
    • 17 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 2002
    Consegnato il 17 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Garage premises at savile st,sheffield,south yorkshire with all buildings,fixtures,plant,machinery,fittings and apparatus whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Fiat Auto Financial Services Limited
    Transazioni
    • 17 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 26 apr 2002
    Consegnato il 14 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that land and buildings on the south and south east side of savile street sheffield. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 27 set 2000
    Consegnato il 05 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at broombank road chesterfield trading estate sheepbridge chesterfield DY125443. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 nov 1999
    Consegnato il 06 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    445 abbeydale road sheffield t/no;-SYK15831 SYK276503 SYK238211 SYK20841. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 05 ott 1999
    Consegnato il 16 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at whitting valley chesterfield derbyshire.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 07 mag 1999
    Consegnato il 18 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at station road old whittington chesterfield derbysire t/no;-=DY76011. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 ott 1997
    Consegnato il 25 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 20TH december 1996 and this charge as defined therein
    Brevi particolari
    Garage premises being the former oswald record buildings at brimington road north chesterfield derbyshire together with all buildings (whether completed or not) fixtures plant and machinery and apparatus (other than tenants fixtures and fittings).
    Persone aventi diritto
    • Fiat Auto UK Limited
    Transazioni
    • 25 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 06 nov 1996
    Consegnato il 13 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land in station road whittington moor chesterfield t/no: DY205612 (part) and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 03 giu 1996
    Consegnato il 06 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a oswald record, brimington road, north chesterfield, derbyshire t/no. DY57267 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 02 ott 1995
    Consegnato il 12 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 126 station road, whittington moor chesterfield derbyshire t/no: DY163729 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 01 giu 1995
    Consegnato il 06 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as the land and buildings on the eastern side of station road whittington moor chesterfield derbyshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 05 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Land garage & premises at birmington road north chesterfield derbyshire.
    Persone aventi diritto
    • Fiat Auto U.K. Limited
    Transazioni
    • 05 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 nov 1994
    Consegnato il 05 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land, garage and premises at birmingham road north chesterfield derbyshire.
    Persone aventi diritto
    • Fiat Inventory Services Limited
    Transazioni
    • 05 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 01 lug 1994
    Consegnato il 08 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as or being land on the north side of station road, old whittington,chesterfield derbyshire title no dy 124886 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,
    Transazioni
    • 08 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0